KIDDICRAFT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KIDDICRAFT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00798901 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KIDDICRAFT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova KIDDICRAFT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 3rd Floor The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KIDDICRAFT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HESTAIR KIDDICRAFT LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| KIDDICRAFT LIMITED | 01 apr 1964 | 01 apr 1964 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KIDDICRAFT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per KIDDICRAFT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Michael Joseph Pellegrino come amministratore in data 01 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Robert John Normile come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Prashant Bapna il 26 ott 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Mattel Uk Limited come persona con controllo significativo il 27 apr 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ England a 3rd Floor the Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ in data 27 apr 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di Mattel Uk Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Mattel House Vanwall Business Park Vanwall Road Maidenhead Berkshire SL6 4UB a The Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ in data 06 apr 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Prashant Bapna il 21 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Dean William Ikin come amministratore in data 11 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Prashant Bapna come amministratore in data 11 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Wendy Elizabeth Hill come amministratore in data 03 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Dominic Julian Geddes come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Dean William Ikin il 10 nov 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Chi sono gli amministratori di KIDDICRAFT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNG, Sukhjiwan Kaur | Segretario | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | British | 106672290002 | ||||||
| BAPNA, Prashant | Amministratore | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | England | Indian | 254409830003 | |||||
| HICK, Michael Brian | Amministratore | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | United Kingdom | British | 181935360002 | |||||
| PELLEGRINO, Michael Joseph | Amministratore | Continental Boulevard El Segundo 333 California 90245 United States | United States | American | 279596470001 | |||||
| CHEVALLIER, Michael John Mayne | Segretario | 40 Fletcher Road Chiswick W4 5AS London | British | 1233360001 | ||||||
| COUNTE, Ronald David | Segretario | 144 Northampton Road LE16 9HF Market Harborough Leicestershire | British | 45256000001 | ||||||
| DESAI, Bimal | Segretario | 24 Springfield Road SL6 2YN Maidenhead Berkshire | British | 80089020001 | ||||||
| GARSIDE, Cliff | Segretario | 8 Deyncourt DH1 3QB Durham | British | 56344140001 | ||||||
| MAWBY, John David | Segretario | The Homestead Main Street Lyddington LE15 9LS Oakham Leicestershire | British | 54979840001 | ||||||
| ALLMARK, David | Amministratore | Castle Street OX10 8DW Wallingford Park Farm House Oxfordshire | England | British | 127080930002 | |||||
| ALLMARK, David | Amministratore | Little Acorns Main Street Stoke Row RG9 5RB Henley On Thames Oxfordshire | British | 69860640002 | ||||||
| BENISON, Graham Ernest | Amministratore | Heather Cottage School Lane Lower Swell GL54 1LH Cheltenham Gloucestershire | British | 61693570001 | ||||||
| BINGHAM, William | Amministratore | Close Hill Naunton GL54 3AA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 113609900001 | |||||
| CHRISTMAN, Steven | Amministratore | 28 Llanvair Drive SL5 9HT South Ascot Berkshire | American | 100016200001 | ||||||
| DOWNS, Kevin | Amministratore | 21 Gleneagles Drive Stretton DE13 0YG Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 14395290001 | |||||
| GEDDES, Dominic Julian | Amministratore | Mattel House Vanwall Business Park SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead Berkshire | England | British | 31394560003 | |||||
| GUARISCO, William Salvatore | Amministratore | Jagerslaan 9 2243 Eh Wassenaar Netherlands | Usa | 46054880001 | ||||||
| HARPER, John Laurence | Amministratore | Framley Startins Lane SL6 9AN Cookham Dean Berkshire | England | British | 177644130001 | |||||
| HILL, Wendy Elizabeth | Amministratore | Mattel House Vanwall Business Park SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead Berkshire | England | British | 179051940002 | |||||
| HORTON, Denis Edward | Amministratore | 31 Bedford Road Moor Park HA6 2AY Northwood Middlesex | British | 20007900002 | ||||||
| IKIN, Dean William | Amministratore | Mattel House Vanwall Business Park SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead Berkshire | England | Australian | 162397500004 | |||||
| ISITT, Christopher John Shute | Amministratore | 5 West End Cholsey OX10 9LW Wallingford Oxfordshire | British | 49272840001 | ||||||
| JACKSON, Joanne | Amministratore | 7039 Salt Road 14031 Clarance New York U S A | American | 1170400001 | ||||||
| JEANS, Michael | Amministratore | 83 Marlow Bottom SL7 3NA Marlow Buckinghamshire | British | 50463930001 | ||||||
| JORDAN, Jacqueline Emily | Amministratore | 19 Woodlands Grove TW7 6NS Isleworth Middlesex | British | 94380010001 | ||||||
| KINGSTON, Michael Kevin | Amministratore | 5 Beechingstoke SL7 1JH Marlow Buckinghamshire | Irish | 1389290001 | ||||||
| LAW, Monica | Amministratore | 317 Regent Street LO5 1JO Niagara On The Lake Ontario Canada | Canadian | 34333500001 | ||||||
| MAWBY, John David | Amministratore | The Homestead Main Street Lyddington LE15 9LS Oakham Leicestershire | British | 54979840001 | ||||||
| MURTHA, Eugene | Amministratore | Wayfield 1a Gossmore Lane SL7 1QQ Marlow Buckinghamshire | Us Citizen | 76216870001 | ||||||
| NORMILE, Robert John | Amministratore | 333 Continental Boulevard El Segundo California 90245 United States | United States | American | 163804110001 | |||||
| ORAVEC, Bruce Joseph | Amministratore | 30 Mill Road Boxford Masachusetts 01921 Usa | Usa | 25153800001 | ||||||
| PEAN, Jean Christophe | Amministratore | Danes Place New Road RG9 3LG Lower Shiplake Oxfordshire | French | 94379490001 | ||||||
| REDDY, Sandeep Rajaram | Amministratore | Flat 5 24 Harcourt Terrace SW10 9JR London | Indian | 112471610001 | ||||||
| ROCHE, Adrian Edward | Amministratore | Burcombe House Chalford Hill GL6 8EN Stroud Gloucestershire | British | 12414150001 | ||||||
| SANDERSON, Antony Richard | Amministratore | 3 Carlton Grange Gosforth, Newcastle Upon Tyne NE3 4QF Ne3 4qf | United Kingdom | British | 114998910001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KIDDICRAFT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattel Uk Limited | 06 apr 2016 | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
KIDDICRAFT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 28 mag 1982 Consegnato il 11 giu 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or hestair kiddieft group limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0