INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED

INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINDUSTRIOUS ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00801273
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Redfern House
    29 Jury Street
    CV34 4EH Warwick
    Warwickshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J. SAVILLE GORDON ESTATES LIMITED01 dic 199501 dic 1995
    J. SAVILLE GORDON DEVELOPMENTS LIMITED18 ago 198718 ago 1987
    COMMERCIAL & FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED16 apr 196416 apr 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Copse Cottage Hunninhgam House Farm Hunningham Leamington Spa Warwickshire CV33 9EW in data 05 nov 2009

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 ott 2009

    LRESSP

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    9 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    12 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    11 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    11 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MELIA, Ian Charles
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    Segretario
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    British36647460001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish6069370001
    KEOGAN, John Stephen Philip
    Fox Cottage
    Market Square Kineton
    CV35 0LP Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Fox Cottage
    Market Square Kineton
    CV35 0LP Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish60874620002
    MELIA, Ian Charles
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    Amministratore
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    UkBritish36647460001
    EDWARDS, John William
    The Garden House Wolverton Road
    Norton Lindsey
    CV35 8LJ Warwickshire
    Segretario
    The Garden House Wolverton Road
    Norton Lindsey
    CV35 8LJ Warwickshire
    British44610010001
    HUTCHINSON, Terence Gordon
    64 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DQ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    64 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DQ Solihull
    West Midlands
    British6199560001
    ALEXANDER, Mark Henry Campbell
    Perrymill Farm
    Inkberrow
    WR7 4JQ Worcester
    Amministratore
    Perrymill Farm
    Inkberrow
    WR7 4JQ Worcester
    United KingdomBritish60875240001
    CLIVE, Nicholas Richard
    South House Roke Marsh
    Roke
    OX10 6JB Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    South House Roke Marsh
    Roke
    OX10 6JB Wallingford
    Oxfordshire
    British65521850001
    FAIR, David Phillip
    25 Everitt Drive
    Knowle
    B93 9EP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    25 Everitt Drive
    Knowle
    B93 9EP Solihull
    West Midlands
    British36039160001
    GOGGIN, Cyril Augustine
    16 Crosbie Road
    Harborne
    B17 9BE Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    16 Crosbie Road
    Harborne
    B17 9BE Birmingham
    West Midlands
    British16864660001
    HUTCHINSON, Terence Gordon
    64 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DQ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    64 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DQ Solihull
    West Midlands
    British6199560001
    SAVILLE, David John
    Avonside
    Grange Road Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Avonside
    Grange Road Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    British90607320001
    SAVILLE, John David
    Barrels Park Ullenhall
    B95 5NQ Henley-In-Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    Barrels Park Ullenhall
    B95 5NQ Henley-In-Arden
    Warwickshire
    British15406400001

    INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental trust deed made between industrious estates limited and industrious trading estates limited and industrious estates limited, industrious coventry (C.I.) limited, industrious debenture UK limited, industrious debenture (jersey) general partner limited and royal exchange trust company limited
    Creato il 10 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the original stock issued by industrious limited (formerly J. saville gordon group P.L.C.)(the issuer) and all other moneys secured by the trust deed under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company charges in favour of the trustee by way of floating charge the company's underaking and all its property, rights and assets, present and future, wheresoever situate (including uncalled capital);. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 13 december 2002 and
    Creato il 09 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1.56 acres at southhook potteries kilmarnock ayrshire scotland.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 apr 1996
    Consegnato il 24 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-unit 1 charlton mead trading estate hoddesdon hertfordshire together with all buildings and fixtures thereon, floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment and assigns the goodwill of the business (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 ago 1995
    Consegnato il 09 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 5 edward street bath t/no.AV175891 and all buildings fixtures and goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 ago 1995
    Consegnato il 09 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 22-24 leys avenue letchworth herts t/no.HD214503 and all buildings fixtures and goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28TH april 1995
    Creato il 25 apr 1995
    Consegnato il 12 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Offices and premises k/a 228 union street, aberdeedn. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 apr 1994
    Consegnato il 16 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 635 chester road sutton coldfield west midlands t/no.WM266465 and goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 22 lug 1992
    Consegnato il 30 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    9 rutland square edinburgh and 63 clydesdale street hamilton.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1,3 and 5 lowerfield road, 226,228,230 and 232 wellington road soth stockport manchester t/ns:GM351635 GM333717, GM341985, GM351634, GM351635, GM351636 and GM351637. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 26 and 28 liscard crescent wallasey merseyside t/n:MS61594. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 71 wokingham road reading berkshire t/n:BK38913. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 endcliffe crescent and 117 ashdell road sheffield south yorkshire t/n:SYK199329. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 4 salisbury road leicester t/n:LT17887. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 153 stanley road bootle merseyside t/n:MS211576. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 ago 1989
    Consegnato il 03 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the east side of town road harley stoke on trent staffs t/no sf 241778 goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 23 giu 1989
    Consegnato il 06 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) 30/58 la porte precinct grangemouth 2) southhook potteries western road kilmarnock 3) 209 union street aberdeen 4) 55 & 88 high street fort william 5) 42 east port dunfermline 6) caledonia house,academy street inverness 7) 58/60 high street peebles.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 08 dic 1988
    Consegnato il 20 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) 14 bank st galashields.2) 12 la porte precinct grangemouth.3) 85 high street hawick.4) 197 north high st.musselburgh.5) 31A high st selkirk.various properties see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 01 dic 1988
    Consegnato il 09 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) investment house union row aberdeen 2) 130 great western rd aberdeen 3) 957 acres at castle st alloa.4) 264 sq yrds at 120 auchionairn rd glasgow.5) 365/381 byres road glasgow.6) 90 comlachie st glasgow.7) 588/560 & 588/598 lawmoor street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 11 lug 1988
    Consegnato il 25 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    36.215 acres,678.3 Square metres with relative servitude and other rights raiths farm,dyce aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 07 mar 1988
    Consegnato il 28 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) 4.28 acres under exception at invergorden industrial estate.2) dalbeath farm cowdenbeath.3) 20/31 dogs street dundee.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1988
    Consegnato il 20 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the west side of westbury road clayton newcastle under lyme t/no sf 218002 goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1988
    Consegnato il 20 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land to the north west of bruntcliffe lane morley leeds goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1988
    Consegnato il 20 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a units 1-7 queen street morley leeds t/no wyk 359098 goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1988
    Consegnato il 20 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a premises in albion street & commercial street morley leeds goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1988
    Consegnato il 20 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 4,5 & 6 manor park industrial estate manor road cheltenham gloucs goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INDUSTRIOUS ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 nov 2010Data di scioglimento
    19 ott 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy James Heaselgrave
    Redfern House 29 Jury Street
    CV34 4EH Warwick
    Praticante
    Redfern House 29 Jury Street
    CV34 4EH Warwick

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0