MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00808924 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MARLEY PROPERTIES LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
NEWLAY TILES LIMITED | 12 giu 1964 | 12 giu 1964 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da - London Road Wrotham Heath Sevenoaks Kent TN15 7RW a 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 02 mag 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lichfield Road Burton-on-Trent DE14 3HD | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Terence John Helmore come amministratore in data 23 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Paul Gregory Reed come amministratore in data 01 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dirk Jacobs come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Terence John Helmore il 17 ott 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Suffolk Way Sevenoaks Kent TN13 1SD* in data 17 ott 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Victor Holmes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEAKMAN, David | Segretario | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | 155453200001 | |||||||
REED, Paul Gregory | Amministratore | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | England | British | Director | 103831950002 | ||||
SPEAKMAN, David | Amministratore | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | England | British | Director | 100820890007 | ||||
ARNOLD, Keith James | Segretario | 4 Hillcrest The Green Horsted Keynes RH17 7AD Haywards Heath West Sussex | British | 1268330002 | ||||||
FENNELL, Susan Joy | Segretario | Suffolk Way TN13 1SD Sevenoaks 1 Kent | British | 90959150001 | ||||||
MUSGRAVE, David John Anthony | Segretario | Coppers Fordcombe Road TN11 8DP Penshurst Kent | British | 28436740001 | ||||||
MUSGRAVE, David John Anthony | Segretario | Coppers Fordcombe Road TN11 8DP Penshurst Kent | British | 28436740001 | ||||||
SORENSEN, Phillip Alan | Segretario | Three Gables TN8 6AJ Edenbridge Kent | British | 806340001 | ||||||
BAKER, Peter Robert | Amministratore | 4 Chilton Ridge Hatch Warren RG22 4RG Basingstoke Hampshire | British | Chartered Surveyor | 7226090003 | |||||
BEENHAM, Christopher Gordon | Amministratore | Ford End House Ford End Clavering CB11 4PU Saffron Walden Essex | British | Finance Director | 30845480001 | |||||
BEVERIDGE, Robert Erskine | Amministratore | Little Boundes Little Boundes Close Southborough TN4 0RS Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Solicitor | 7142930003 | ||||
CARIS, Liliane Frieda Jacoba | Amministratore | Mechelsesteeweg 124/4 Be-2018 Antwerp Belgium | Belgium | Accountant | 68460480001 | |||||
DIX, Susan Margaret | Amministratore | 13 Cross Lane Gardens Ticehurst TN5 7HY Wadhurst East Sussex | England | British | Grp Financial Controller | 68460630001 | ||||
GRIFFITHS, Glynn | Amministratore | 34 Marlings Park Avenue BR7 6QW Chislehurst Kent | England | British | Actuary | 52022650002 | ||||
HARRIS, Robert Lindsay | Amministratore | Suffolk Way TN13 1SD Sevenoaks 1 Kent | England | British | Investment Manager | 51853520002 | ||||
HELMORE, Terence John | Amministratore | London Road Wrotham Heath TN15 7RW Sevenoaks - Kent England | England | British | Pension Manager | 99619980001 | ||||
HOLMES, Victor John Ralph | Amministratore | Suffolk Way TN13 1SD Sevenoaks 1 Kent | England | British | Group Treasurer | 118449030001 | ||||
JACOBS, Dirk Maria Jozef Jacobus | Amministratore | Suffolk Way TN13 1SD Sevenoaks 1 Kent | Belgium | Belgian | Financial Holdings Manager | 135331020001 | ||||
JAMES, Harry Colin | Amministratore | Little Broad Reed Farm Hadlow Down TN22 4EL Uckfield East Sussex | British | Executive Director | 36861330001 | |||||
KIRBY, Christopher Mansfield | Amministratore | 15 Fryerning Lane CM4 0DD Ingatestone Essex | England | British | Accountant | 38151730001 | ||||
MUSGRAVE, David John Anthony | Amministratore | Coppers Fordcombe Road TN11 8DP Penshurst Kent | British | Company Secretary | 28436740001 | |||||
SHARP, Kenneth Charles | Amministratore | Begonialaan 22 3080 Vossem Belgium | British | Chartered Accountant | 32251740002 |
MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed | Creato il 11 nov 1998 Consegnato il 17 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 3(a) of the mph deed of guarantee | |
Brevi particolari Floating charge over all undertaking property and assets including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 17 mar 1981 Consegnato il 23 mar 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 31 oct 1980. | |
Brevi particolari F/H land in lichfield road, wednesfield, wolverhampton. Title no-wm 142500 charge over all fixed and movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. All the estate and interest of the company of and in the agreement dated 31/10/1980, and all benefits accruing to the mortgage there under. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 23 ott 1967 Consegnato il 01 nov 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Debenture stock of the morley title (holding) co LTD amounting to £5,0000,000 secured by two trust deeds dated 14/2/58 & 8/5/63 | |
Brevi particolari (Floating charge). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
MARLEY PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0