FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED

FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00814782
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNCAN POCOCK (INSURANCE BROKERS) LIMITED02 lug 199002 lug 1990
    DONALD DUNCAN (INSURANCE BROKERS) LIMITED06 ago 196406 ago 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Towergate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 15 Canada Square London E14 5GL in data 11 set 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 ago 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr David Christopher Ross come amministratore in data 20 dic 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 20 dic 2016

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jennifer Owens come segretario in data 01 mar 2016

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Stephen Mugge il 25 nov 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Scott Egan come amministratore in data 14 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Stephen Mugge come amministratore in data 11 set 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ago 2015

    Stato del capitale al 26 ago 2015

    • Capitale: GBP 42,857
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Steven Hodges come amministratore in data 17 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ago 2014

    Stato del capitale al 18 ago 2014

    • Capitale: GBP 42,857
    SH01

    Nomina di Jennifer Owens come segretario in data 25 nov 2013

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    222043460001
    MUGGE, Mark Stephen
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish162920630005
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    BROWN, Jeffrey Marson
    4 Johnsdale
    RH8 0BW Oxted
    Surrey
    Segretario
    4 Johnsdale
    RH8 0BW Oxted
    Surrey
    British6406870001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    152541050001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161869930001
    CRATON, Timothy Charles
    Downings
    Quarry Close
    RH8 9HG Oxted
    Surrey
    Segretario
    Downings
    Quarry Close
    RH8 9HG Oxted
    Surrey
    British76055420004
    HOMEWOOD, Stephen Kenneth
    92 Canterbury Avenue
    DA15 9AS Sidcup
    Kent
    Segretario
    92 Canterbury Avenue
    DA15 9AS Sidcup
    Kent
    British17243950001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156624940001
    MARTIN, Kim Ian
    Little Dene
    13 Manor Rise
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    Segretario
    Little Dene
    13 Manor Rise
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    British11165290001
    OWENS, Jennifer
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    183300440001
    CHAPPELL, Michael John
    18 St Johns Meadow
    Blindley Heath
    RH7 6JU Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    18 St Johns Meadow
    Blindley Heath
    RH7 6JU Lingfield
    Surrey
    British7661880001
    CLARKE, Benjamin David
    46 Crossways Avenue
    RH19 1HZ East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    46 Crossways Avenue
    RH19 1HZ East Grinstead
    West Sussex
    British74723790001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    EnglandBritish59873490009
    DESSENT, Peter John
    Roundhouse Cottage
    Woodhurst Lane
    RH8 9ED Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Roundhouse Cottage
    Woodhurst Lane
    RH8 9ED Oxted
    Surrey
    EnglandBritish7661890004
    EGAN, Scott
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    EnglandBritish170703910001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United KingdomBritish58444370003
    HOMER, Andrew Charles
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    EnglandBritish13483140003
    HOMEWOOD, Stephen Kenneth
    92 Canterbury Avenue
    DA15 9AS Sidcup
    Kent
    Amministratore
    92 Canterbury Avenue
    DA15 9AS Sidcup
    Kent
    British17243950001
    IBBS, John Albert
    89 Phoenix Drive
    Wateringbury
    ME18 5RS Maidstone
    Kent
    Amministratore
    89 Phoenix Drive
    Wateringbury
    ME18 5RS Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish123795360001
    LOFTUS, Joseph
    28 Willow Ridge
    Turners Hill
    RH10 4PN Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    28 Willow Ridge
    Turners Hill
    RH10 4PN Crawley
    West Sussex
    British19601860001
    MACIVER, Kenneth
    12 Norfolk Heights
    Church Road
    TN1 1JD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    12 Norfolk Heights
    Church Road
    TN1 1JD Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish70920700003
    MARSHGREEN, John William
    Marringdean Manor
    Marringdean Road
    RH14 9HF Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Marringdean Manor
    Marringdean Road
    RH14 9HF Billingshurst
    West Sussex
    British6406900004
    MARTIN, Kim Ian
    Little Dene
    13 Manor Rise
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Little Dene
    13 Manor Rise
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    EnglandBritish11165290001
    PALMER, Julian Claude
    12 Cyprus Road
    Hatch Warren
    RG22 4UY Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    12 Cyprus Road
    Hatch Warren
    RG22 4UY Basingstoke
    Hampshire
    British51776320001
    PALMER-MINNIS, Nigel Anthony
    138 Limpsfield Road
    CR2 9EF Sanderstead
    Surrey
    Amministratore
    138 Limpsfield Road
    CR2 9EF Sanderstead
    Surrey
    British51776240004
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United KingdomBritish99066410001
    STEPHENS, Michael John
    8 Pine Walk
    CR3 5EN Caterham
    Surrey
    Amministratore
    8 Pine Walk
    CR3 5EN Caterham
    Surrey
    British19601880001
    WHITE, Andrew Stephen
    15 Firlands
    Langshott
    RH6 9BL Horley
    Surrey
    Amministratore
    15 Firlands
    Langshott
    RH6 9BL Horley
    Surrey
    British74723740001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Duncan Pocock (Holdings) Limited
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    England
    06 apr 2016
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione03329491
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 18 ott 2002
    Consegnato il 24 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £16,159.77.
    Persone aventi diritto
    • The Wedge Property Company Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 17 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank and the hedging bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank and the Hedging Bank (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,517,000 together with interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a the l/h premises 110 station road east oxted surrey, 145STATION road east oxted surrey, sheldon house station road east oxted surrey (as demised in the leases). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter John Dessent and John William Marshgreen
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 ott 2001
    Consegnato il 27 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 26 october 1998 (as defined)
    Brevi particolari
    The interest in the deposit of £12,043.75.
    Persone aventi diritto
    • Wedge Property Company Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Twelve thousand forty three pounds and seventy five pence (£12,043.75).
    Persone aventi diritto
    • The Wedge Property Company Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 23 apr 1999
    Consegnato il 30 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 436 limpsfield road warlingham. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 23 feb 1996
    Consegnato il 29 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 23 feb 1996
    Consegnato il 29 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit
    Creato il 01 nov 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of account number 7510903 of the company with lloyds bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit
    Creato il 01 nov 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of account number 7510903 with lloyds bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 1994
    Consegnato il 07 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of deposit account moneys
    Creato il 28 feb 1991
    Consegnato il 07 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £150,000 with lloyds banks PLC, elephant and castle branch, london, SE1 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 1984
    Consegnato il 20 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises situate at 106 grove vale, east dulwich, london SE22 T.N. ln 80024 l/h property situate at 67 nottingham road, nottingham london SE9 4QZ T.N. sgl 269463 fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 20 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 mag 2018Data di scioglimento
    15 ago 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0