ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00819139
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WS ATKINS PLANNING AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED03 apr 198903 apr 1989
    WS ATKINS MANAGEMENT CONSULTANTS16 mar 198716 mar 1987
    ATKINS PLANNING10 set 196410 set 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re dividend 11/12/2014
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Alun Hughes Griffiths come amministratore in data 30 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan James Cullens come amministratore in data 01 lug 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Heath Stewart Drewett il 08 ago 2012

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Richard Webster come amministratore in data 01 gen 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Steven Johnson come amministratore in data 30 nov 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Steven Johnson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Purser come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Chi sono gli amministratori di ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British85595860003
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish189297280001
    DREWETT, Heath Stewart
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish167727030003
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish85595860003
    DAVID, Katie Charmian
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    British73696680003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Segretario
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Segretario
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Segretario
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    TOMALIN, Richard Howarth
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    Segretario
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    British13199870002
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BINNIE, Christopher Jon Anthony
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    Amministratore
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    British14298460001
    CLANCY, Brian Charles
    97 Winchester Street
    SW1V 4NX London
    Amministratore
    97 Winchester Street
    SW1V 4NX London
    British70735350001
    COLLINS, Roger Arthur Forster
    Three Oaks 166 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    Amministratore
    Three Oaks 166 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    EnglandBritish30542670001
    CORRIE, Robert Keith
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish35957190001
    CUTHBERT, Richard Harry
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    Amministratore
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    United KingdomBritish43573230002
    FYFE, John, Professor
    Watermead
    Lakes Lane
    GU8 5LQ Witley
    Surrey
    Amministratore
    Watermead
    Lakes Lane
    GU8 5LQ Witley
    Surrey
    United KingdomBritish3128160001
    GRIFFITHS, Alun Hughes
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish47764900002
    HEALY, William John
    36 Shaftesbury Road
    RH10 7HD Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    36 Shaftesbury Road
    RH10 7HD Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish91089340001
    JAMES, David Stuart
    Merfield Straight Lane
    Rode
    BA3 6PG Bath
    Avon
    Amministratore
    Merfield Straight Lane
    Rode
    BA3 6PG Bath
    Avon
    United KingdomBritish19034030002
    JARVIS, Richard Douglas
    Woodhay
    White Lane
    GU4 8PU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Woodhay
    White Lane
    GU4 8PU Guildford
    Surrey
    EnglandBritish16756850002
    JEFFRIES, Michael Makepeace Eugene
    Glade Lodge
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Glade Lodge
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    British15114890006
    JOHNSON, Steven
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish161365240001
    MACLEOD, Robert James
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    Amministratore
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    United KingdomBritish90186680002
    MARKS, Charles Theodore
    24 Valley Road
    CR8 5BQ Kenley
    Surrey
    Amministratore
    24 Valley Road
    CR8 5BQ Kenley
    Surrey
    United KingdomBritish67281260001
    MCCLEAN, James Constantine Stuart
    Waterfield, Petworth Road
    Chiddingfold
    GU8 4UF Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Waterfield, Petworth Road
    Chiddingfold
    GU8 4UF Godalming
    Surrey
    EnglandBritish121347960001
    MORGAN, David Graham
    Glendale Deepdene Park Road
    RH5 4AW Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Glendale Deepdene Park Road
    RH5 4AW Dorking
    Surrey
    British18966920001
    PURSER, Ian Robert
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish61343830005
    SANDON, Andrew Charles
    5 Eastwick Park Avenue
    Bookham
    KT23 3LY Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    5 Eastwick Park Avenue
    Bookham
    KT23 3LY Leatherhead
    Surrey
    British30542680001
    SMITH, Stephen
    54 Spring Lane
    Fordham Heath
    CO3 9TG Colchester
    Essex
    Amministratore
    54 Spring Lane
    Fordham Heath
    CO3 9TG Colchester
    Essex
    British82293290001
    SOLE, Francis Alfred
    71 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    71 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    Cambridgeshire
    British16756860001
    SOUTHERN, Andrew Clive, Dr
    Flat 1 35 Eccleston Square
    Pimlico
    SW1V 1PB London
    Amministratore
    Flat 1 35 Eccleston Square
    Pimlico
    SW1V 1PB London
    British47764970003
    THIRKETTLE, David
    Yew Trees Cottage Old Down Hill
    Tockington
    BS12 4PA Bristol
    Avon
    Amministratore
    Yew Trees Cottage Old Down Hill
    Tockington
    BS12 4PA Bristol
    Avon
    British18966930001

    ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second fixed and floating debenture
    Creato il 27 feb 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 18 dic 2002
    Consegnato il 27 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over book debts.
    Creato il 25 apr 1985
    Consegnato il 02 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All bookdebts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • Clydedale Bank Public Limited Company.
    Transazioni
    • 02 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 13 feb 1978
    Consegnato il 22 feb 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Limited
    Transazioni
    • 22 feb 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0