PETROPLUS MARKETING LIMITED

PETROPLUS MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPETROPLUS MARKETING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00819969
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PETROPLUS MARKETING LIMITED?

    • (5151) /

    Dove si trova PETROPLUS MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Petroplus House St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PETROPLUS MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PHILLIPS PETROLEUM PRODUCTS LIMITED18 set 196418 set 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di PETROPLUS MARKETING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PETROPLUS MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Joseph Dunlap Watson come amministratore in data 29 feb 2012

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ago 2011

    Stato del capitale al 22 ago 2011

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Chester Kuchta come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Karyn Ovelmen come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Joseph Dunlap Watson come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da North Tees Site, Port Clarence Middlesbrough Cleveland TS2 1TT in data 26 apr 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Jonathan Peter Barden come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bruce Jones come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Gayda come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Angela Lesley Helen Graham come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    9 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di PETROPLUS MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAHAM, Angela Lesley Helen
    St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    Petroplus House
    United Kingdom
    Segretario
    St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    Petroplus House
    United Kingdom
    147781040001
    BARDEN, Jonathan Peter
    St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    Petroplus House
    United Kingdom
    Amministratore
    St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    Petroplus House
    United Kingdom
    EnglandBritish149328020001
    GAYDA, Michael Daniel
    6300 Zug
    FOREIGN
    Fadenstrasse 32
    Switzerland
    Segretario
    6300 Zug
    FOREIGN
    Fadenstrasse 32
    Switzerland
    Other114368770002
    REDRUP, Leslie Charles Ernest
    Ashlyn House Estate Farm
    South Drive Ossemsley
    BH25 5TL New Milton
    Hampshire
    Segretario
    Ashlyn House Estate Farm
    South Drive Ossemsley
    BH25 5TL New Milton
    Hampshire
    British10059960001
    TAPP, Robert John
    5 The Grange
    Grange Lane
    RG27 8HH Hartley Witney
    Hampshire
    Segretario
    5 The Grange
    Grange Lane
    RG27 8HH Hartley Witney
    Hampshire
    British40252320001
    VAN RIETSCHOTEN, Harry Frederik Constantijn
    Schiedamsesingel 161-A
    FOREIGN Rotterdam
    3012 Bb
    The Netherlands
    Segretario
    Schiedamsesingel 161-A
    FOREIGN Rotterdam
    3012 Bb
    The Netherlands
    Dutch73868900001
    WATSON, Susan Elizabeth
    Lambeck Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    Segretario
    Lambeck Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    British14482850001
    ADAMSON, Neil John
    18 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    18 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish101437550001
    BARTEN, Antonius Wilhelmus Hubertus Maria
    Wethouder Feskenstraat 15
    4873 Hg Etten-Leur
    The Netherlands
    Amministratore
    Wethouder Feskenstraat 15
    4873 Hg Etten-Leur
    The Netherlands
    Dutch78603220001
    BRENNAN, Michael Peter
    3 Farr Holme
    Blackwell
    DL3 8QZ Darlington
    County Durham
    Amministratore
    3 Farr Holme
    Blackwell
    DL3 8QZ Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish73868600001
    BRENTON, Neil John
    13 Bourne Firs
    Lower Bourne
    GU10 3QD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    13 Bourne Firs
    Lower Bourne
    GU10 3QD Farnham
    Surrey
    British15265530001
    CHAMBERLAIN, Virgil Ralph
    Summerlee Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Summerlee Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    American53961110003
    ENGELEN, Nico
    Luzernerstrasse 206
    Merlischachen
    6402
    Switzerland
    Amministratore
    Luzernerstrasse 206
    Merlischachen
    6402
    Switzerland
    Dutch73879590001
    HILL, James Charles
    Mayfield Hawks Hill
    Guildford Road
    KT22 9DY Fetcham
    Surrey
    Amministratore
    Mayfield Hawks Hill
    Guildford Road
    KT22 9DY Fetcham
    Surrey
    Republic Of Ireland10149140001
    HORLER, Nicholas Wenham
    The Old Hall Main Street
    Hunningham
    CV33 9DY Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Hall Main Street
    Hunningham
    CV33 9DY Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish62374390001
    JONES, Bruce Allen
    27a 6312
    Steinhausen
    Bannstrasse
    Switzerland
    Amministratore
    27a 6312
    Steinhausen
    Bannstrasse
    Switzerland
    SwitzerlandUnited States114369020003
    KENT, David Elvin
    6 Lobelia Road
    Bisley
    GU24 9SE Woking
    Surrey
    Amministratore
    6 Lobelia Road
    Bisley
    GU24 9SE Woking
    Surrey
    British62344850001
    KUCHTA, Chester James
    Grafenausrasse
    Zug
    Ch-6300
    Switzerland
    Amministratore
    Grafenausrasse
    Zug
    Ch-6300
    Switzerland
    SwitzerlandUnited States114368560002
    MCGEE, Henry Isaac
    Dorney House
    11 Lytton Park, Sandy Lane
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Dorney House
    11 Lytton Park, Sandy Lane
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    American71418050002
    OVELMEN, Karyn
    6300 Zug
    Chamer Fussweg 19
    Switzerland
    Amministratore
    6300 Zug
    Chamer Fussweg 19
    Switzerland
    SwitzerlandAmerican114368960002
    READ, Terence Frederick Charles
    28 Avenue Road
    GU14 7BL Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    28 Avenue Road
    GU14 7BL Farnborough
    Hampshire
    EnglandBritish15117930001
    RISLEY, Allyn Wayne
    Summerlee
    Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Summerlee
    Elmstead Road
    KT14 6JB West Byfleet
    Surrey
    Us Citizen40261740002
    SANDERSON, Ian
    15 Fosters Grove
    GU20 6JZ Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    15 Fosters Grove
    GU20 6JZ Windlesham
    Surrey
    British30638240001
    SIMPSON, James Alex
    Oxford House Hazel Road
    KT14 6JJ West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Oxford House Hazel Road
    KT14 6JJ West Byfleet
    Surrey
    Usa Citizen55832310002
    SMITH, Clive Brian
    12 All Saints Close
    Glebe Park
    RG11 1WE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    12 All Saints Close
    Glebe Park
    RG11 1WE Wokingham
    Berkshire
    British15265510001
    TARR, Gerald Vaughan
    Heritage 154 The Street
    Puttenham
    GU3 1AU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Heritage 154 The Street
    Puttenham
    GU3 1AU Guildford
    Surrey
    British15265520001
    THOMASON, Stephen Kenneth, Dr
    57 Westover Road
    Downley
    HP13 5HX High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    57 Westover Road
    Downley
    HP13 5HX High Wycombe
    Buckinghamshire
    British78603350001
    WALKER, Nigel Francis Courtenay
    15 Wildcroft Drive
    RG40 3HY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    15 Wildcroft Drive
    RG40 3HY Wokingham
    Berkshire
    British2299940001
    WATSON, Joseph Dunlap
    St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    Petroplus House
    United Kingdom
    Amministratore
    St Mark's Court
    Teesdale
    TS17 6QW Stockton On Tees
    Petroplus House
    United Kingdom
    SwitzerlandUnited States153796720001
    WILLE, Michael George
    81 Harbord Street
    SW6 6PL London
    Amministratore
    81 Harbord Street
    SW6 6PL London
    British10471770001

    PETROPLUS MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A fixed and floating security document
    Creato il 13 lug 2007
    Consegnato il 25 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The accounts book debts insurances and all related proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. as Security Agent for the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 25 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 18 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest (if any) to and in (a) all rpf debts (b) each UK collection account (c) all debtor letters of credit relating to rpf debts (d) all debtor guarantees relating to rpf debts (e) all letters of indemnity relating to rpf debts (f) all documents of title relating to rpf debts and (g) each prtl policy but only so far as it relates to rpf debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 18 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The accounts book debts other than unbilled debts insurances and all related proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. as Security Agent for the Benefit of the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 mag 2006
    Consegnato il 26 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 26 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 24 feb 2006
    Consegnato il 07 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all present and future a) accounts b) book debts other than unbilled debts and c) insurances and all related proceeds claims of any kind returns of premium and other benefits. By way of floating charge its accounts book debts inventories title documents and insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. as Security Agent for the Benefit of the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 07 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge
    Creato il 24 feb 2006
    Consegnato il 02 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest (if any) to and in (a) all rpf debts (b) each UK collection account (c) all debtor letters of credit relating to rpf debts (d) all debtor guarantees relating to rpf debts (e) all letters of indemnity relating to rpf debts (f) all documents of title relating to rpf debts and (g) each prtl policy but only so far as it relates to rpf debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Shared Secured Parties
    Transazioni
    • 02 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 01 nov 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other shared security party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Discovery (unit c) st marks court teesdale business park, refinery site lease 1 t/no CE184245, refinery site lease 2 t/no CE184246. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 19 apr 2005
    Consegnato il 22 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the security agent and/or any other secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 22 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge and assignment
    Creato il 30 mar 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the terms of the working capital facility (as defined)
    Brevi particolari
    The company's rights, title and interest in and to the secured property. The floating charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0