BOALLOY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBOALLOY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00824155
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BOALLOY LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova BOALLOY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Radnor Park Trading Estate
    West Heath
    CW12 4QA Congleton
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BOALLOY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per BOALLOY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2006

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di BOALLOY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HART, Dawn
    101 Mountsandel Road
    BT52 1TA Coleraine
    County Londonderry
    Segretario
    101 Mountsandel Road
    BT52 1TA Coleraine
    County Londonderry
    British121210700001
    MURRAY, James
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director117271120001
    MURRAY, Margaret Winifred
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director117271100001
    MURRAY, Patrick
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    United KingdomBritishCompany Director117271170001
    MURRAY, Timothy
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    BritishCompany Director117271150001
    HANCOCK, David Stanley
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    Segretario
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    BritishDirector20642940001
    SPENCER, Stanley
    25 Southbank Grove
    CW12 3DU Congleton
    Cheshire
    Segretario
    25 Southbank Grove
    CW12 3DU Congleton
    Cheshire
    British2952280001
    ABEL SMITH, David Francis
    Quenington Old Rectory
    Church Road
    GL7 5BN Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Quenington Old Rectory
    Church Road
    GL7 5BN Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishIndustrial Manager65088820001
    BROADBENT, Edward Gerald
    The Pantiles
    91 Park Lane
    CW11 9EE Sandbach
    Cheshire
    Amministratore
    The Pantiles
    91 Park Lane
    CW11 9EE Sandbach
    Cheshire
    BritishDirector33371710001
    BROWMING, Walter Geoffrey
    Cherry Rise Lynwood
    Hale
    WA15 0NF Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Cherry Rise Lynwood
    Hale
    WA15 0NF Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector18640150001
    BROWN, Gerard
    20 Grey Road
    WA14 4BU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    20 Grey Road
    WA14 4BU Altrincham
    Cheshire
    BritishManaing Director10069910001
    BUCKLEY, David Arthur
    Crows Nest Farm Mill Lane
    Moston
    CW11 3PT Sandbach
    Cheshire
    Amministratore
    Crows Nest Farm Mill Lane
    Moston
    CW11 3PT Sandbach
    Cheshire
    BritishProduction Director6733140001
    DUNCAN, James Blair, Sir
    17 Kingston House South
    Ennismore Gardens
    SW7 1NF London
    Amministratore
    17 Kingston House South
    Ennismore Gardens
    SW7 1NF London
    EnglandBritishBritish Road Federation Ltd3477810001
    GIBB, James
    Tall Trees
    13 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Tall Trees
    13 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    BritishDirector29108210002
    HANCOCK, David Stanley
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    Amministratore
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    BritishDirector20642940001
    HELD, Peter Erich Julius
    13 Princedale Road
    W11 4NW London
    Amministratore
    13 Princedale Road
    W11 4NW London
    BritishDirector35718230001
    JUBB, Andrew James
    Fold Cottage Off Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0QY Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Fold Cottage Off Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0QY Macclesfield
    Cheshire
    BritishDirector41197260001
    POTTER, John Grahame
    42 Goughs Lane
    WA16 8QN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    42 Goughs Lane
    WA16 8QN Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector20642960002
    ROLLASON, William Peter, Dir
    11 Glenrosa Street
    SW6 2QY London
    Amministratore
    11 Glenrosa Street
    SW6 2QY London
    BritishChartered Accountant67354680001
    SAMUELS, Marcus Taylor
    Great Westwood
    Westwood Lane
    GU3 2JE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Great Westwood
    Westwood Lane
    GU3 2JE Guildford
    Surrey
    BritishChartered Accountant109229180001
    SKINNER, Thomas Leonard
    Rutlish House 19 Beech Hall Drive
    SK10 2EF Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Rutlish House 19 Beech Hall Drive
    SK10 2EF Macclesfield
    Cheshire
    BritishDirector20642970001
    VAN ADRICHEM, Adrianus Theodorus Franciscus Ignatius
    The Coach House
    Black Lane
    ST10 2JQ Whiston
    Staffordshire
    Amministratore
    The Coach House
    Black Lane
    ST10 2JQ Whiston
    Staffordshire
    EnglandDutchDirector85041540001
    WISEMAN, Paul
    55 Wykeham Road
    NW4 2SS London
    Amministratore
    55 Wykeham Road
    NW4 2SS London
    BritishDirector2320450001

    BOALLOY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1992
    Consegnato il 02 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H units 7&8 radnor park industrial estate back lane congleton cheshire t/no CH190831.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1992
    Consegnato il 02 ott 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit no 6. radnor park industrial estate back lane congleton cheshire t/no ch 214885.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1992
    Consegnato il 02 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All those f/h units radnor park industrial estrate back lane congleton cheshire t/no ch 314882.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 lug 1992
    Consegnato il 29 lug 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts uncalled capital trade marks trade names inventions goodwill patents by way of a floatingcharge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 1985
    Consegnato il 26 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises off back lane congleton, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 1985
    Consegnato il 11 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises lying to the north east of back lane, congleton title no: ch 120181.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 1985
    Consegnato il 11 mar 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold north-east side of back lane, congleton title no ch 125391.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 26 lug 1984
    Consegnato il 31 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 26-7-84.
    Brevi particolari
    Floating charge on all undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Marling Industries PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 giu 1984
    Consegnato il 29 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold-land hereditaments & premises in back lane, congleton, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 mag 1984
    Consegnato il 25 mag 1984
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 28 gen 1975
    Consegnato il 03 feb 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 lug 1972
    Consegnato il 04 ago 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000
    Brevi particolari
    Land in back lane, congleton, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Mayor, Alderman & Burgesses of Borough of Congleton
    Transazioni
    • 04 ago 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0