SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED

SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSLFC ASSURANCE (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00830572
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?

    • Altre attività ausiliarie all'assicurazione e al finanziamento della previdenza (66290) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Cumberland House
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LINCOLN ASSURANCE LIMITED01 gen 199701 gen 1997
    LAURENTIAN LIFE PLC23 gen 198923 gen 1989
    IMPERIAL TRIDENT LIFE LIMITED01 lug 198701 lug 1987
    TRIDENT LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED03 lug 198603 lug 1986
    IMPERIAL TRIDENT LIFE LIMITED01 giu 198601 giu 1986
    TRIDENT LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED09 dic 196409 dic 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 ago 2017

    14 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT a 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG in data 05 dic 2016

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Matrix House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4DZ a Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT in data 16 ago 2016

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Dirs authorise final dividend of 17.89 02/08/2016
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Declare final dividend of £410000002.50 02/08/2016
    RES13

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 ago 2016

    LRESSP

    Stato del capitale al 01 ago 2016

    • Capitale: GBP 0.40
    6 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 29 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 27 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 28 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2016

    Stato del capitale al 05 mag 2016

    • Capitale: GBP 302,180,000
    SH01

    Nomina di Mr Neville Dean Kent come amministratore in data 03 mag 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Donald Alexander Stewart come amministratore in data 03 mag 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Mark Coombes come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2015

    Stato del capitale al 13 mag 2015

    • Capitale: GBP 302,180,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mag 2014

    Stato del capitale al 02 mag 2014

    • Capitale: GBP 302,180,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOBBS, Margaret Fleur
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    Segretario
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    British74951990001
    GARNER, Katherine Angela
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    Amministratore
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    United KingdomBritish149006830001
    KENT, Neville Dean
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    Amministratore
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    United KingdomBritish44753820002
    DAWBARN, Mark Lupton
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    Segretario
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    British3920290005
    GARNELL, Mary Elizabeth Jane
    Cyprus House
    High Street Chalford
    GL6 8DR Stroud
    Gloucestershire
    Segretario
    Cyprus House
    High Street Chalford
    GL6 8DR Stroud
    Gloucestershire
    British6101450001
    HOBBS, Margaret Fleur
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    Segretario
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    British74951990001
    WILSON, Malcolm George William
    Kings Ride House
    HP18 9RP Brill
    Buckinghamshire
    Segretario
    Kings Ride House
    HP18 9RP Brill
    Buckinghamshire
    British72397640001
    ALDER, Bernard Henry
    Inglewood
    Elkstone
    GL53 9PB Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Inglewood
    Elkstone
    GL53 9PB Cheltenham
    Gloucestershire
    British57055620002
    ANSTEE, Eric Edward
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish76479900001
    ASKARI, Hasan
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish41444890001
    BERRYMAN, Malcolm Leonard
    Kiln Lane
    Otterbourne
    SO21 2EN Winchester
    Otterbourne Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kiln Lane
    Otterbourne
    SO21 2EN Winchester
    Otterbourne Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish114331270002
    BOSCIA, Jon Andrew
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    UsaAmerican153770970001
    BOSCIA, Jon Andrew
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    UsaAmerican153770970001
    BROWN, Bernard George
    Long Hop House
    52 New Road
    KT10 9NU Esher
    Surrey
    Amministratore
    Long Hop House
    52 New Road
    KT10 9NU Esher
    Surrey
    British8598360002
    COOMBES, Stephen Mark
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish101470950001
    DAVIDSON, Anthony Beverley
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish61933730002
    DAVIES, David Wyndham
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish10487980001
    DAWBARN, Mark Lupton
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    Amministratore
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    British3920290005
    FRANKLIN, Christina
    Front Street
    Nympsfield
    GL10 3TY Stroud
    Four Wells Cottage
    Gloucestershire
    Uk
    Amministratore
    Front Street
    Nympsfield
    GL10 3TY Stroud
    Four Wells Cottage
    Gloucestershire
    Uk
    United KingdomBritish85575860002
    FULLER, Janet Christine
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish Canadian146458800001
    GARNER, Katherine Angela
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish149006830001
    GREEN, Michael Anthony
    23 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    Amministratore
    23 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    British51805960002
    HOLSTEIN, Phillip
    8 Wells Rise
    NW8 7LH London
    Amministratore
    8 Wells Rise
    NW8 7LH London
    American69671760001
    KENT, Neville Dean
    Great Washbourne House
    Great Washbourne
    GL20 7AR Tewkesbury
    Gloucester
    Amministratore
    Great Washbourne House
    Great Washbourne
    GL20 7AR Tewkesbury
    Gloucester
    United KingdomBritish44753820002
    MARSH, Richard William, Lord Marsh Of Mannington
    25 Moreton Terrace
    SW1V 2NS London
    Amministratore
    25 Moreton Terrace
    SW1V 2NS London
    British12558860001
    MCMATH, Michael Edward
    1 Hibberts Way
    SL9 8UD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Hibberts Way
    SL9 8UD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British40388880001
    MOSS, Jonathan Stephen
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish144991950001
    NICK, Jeffrey Joseph
    6 Frognal Close
    Hampstead
    NW3 6YB London
    Amministratore
    6 Frognal Close
    Hampstead
    NW3 6YB London
    American58634090002
    PARKINSON, Stephen David
    Chestnut Coppice
    Furzefield Chase, Dormans Park
    RH19 2LU East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    Chestnut Coppice
    Furzefield Chase, Dormans Park
    RH19 2LU East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish89576180001
    REED, Gregory Edward
    Appleshaw
    Cheltenham Road, Pitchcombe
    GL6 6LZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Appleshaw
    Cheltenham Road, Pitchcombe
    GL6 6LZ Stroud
    Gloucestershire
    American54583630004
    ROGERS, Derek John
    Woodlands High Street
    Wanborough
    SN4 0AE Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    Woodlands High Street
    Wanborough
    SN4 0AE Swindon
    Wiltshire
    British51815620001
    ROWE, Benjamin Nathan
    214 Hendon Way
    NW4 3NE London
    Amministratore
    214 Hendon Way
    NW4 3NE London
    United KingdomBritish5648270001
    SHAHEEN, Gabriel L
    Hollywood Vicarage Lane
    SL9 8AS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hollywood Vicarage Lane
    SL9 8AS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    American50946320003
    SHARKEY, Robert John
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadian134441240001
    SHERRIFF, John Baird
    6 Bracken Avenue
    SW12 8BH London
    Amministratore
    6 Bracken Avenue
    SW12 8BH London
    British6203290001

    SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge deed
    Creato il 20 giu 2002
    Consegnato il 08 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 43 old queen st,london; t/no 65657; f/hold property known as 10-14 bank st,carlisle,cumbria; t/no cu 171028 with all buildings trade and other fixtures,fixed plant and machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 mar 2000
    Consegnato il 22 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 23/01/89 and the deed
    Brevi particolari
    By way of charge £13,860 and the amount standing to the credit of the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • S.C.M. Property and Investment Company Limited
    Transazioni
    • 22 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 27 ott 1993
    Consegnato il 28 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    149 belgrave road leicester t/n LT172956ASSIGNS the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 09 lug 1993
    Consegnato il 14 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 36A chapel lane formby together with all buildings and fixtures thereon assings goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 apr 1992
    Consegnato il 15 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 wood street, earl shilton, leicester title no. LT180811 together with all buildings and fixturesthereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 dic 1991
    Consegnato il 10 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 5, 2 station road, earl shilton, leicestershire title no. LT222433 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 dic 1991
    Consegnato il 10 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 4, 1 station road, earl shilton, leicestershire title no. LT239939 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1991
    Consegnato il 21 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 st johns square glastonbury somerset title no st 66850 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 11 feb 1991
    Consegnato il 15 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 14 the talina centre bagleys lane fulham london SW6 assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 gen 1991
    Consegnato il 08 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7/8 the brittox devizes wiltshire together with all buildings & fixtures thereonassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1988
    Consegnato il 28 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 15,15A, & 16 silver street, eastern house bradford on avon wiltshire together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 11 nov 1987
    Consegnato il 30 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 21 & 22 (formerly units 5B & 5C) westfield road, kineton road estate southam, stratford on avon, warwickshire assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 1985
    Consegnato il 12 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings at bristol road south llongbridge birmingham west midlands title no wm 233089 and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mag 1985
    Consegnato il 29 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land or buildings halton station road, sutton weaver chester.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge pursuant to on order of court dated 4/7/85
    Creato il 20 feb 1985
    Consegnato il 09 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 77 parkway london NW1 title nos 421616, ln 53012, ln 53974, 413310, 413291.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1984
    Acquisito il 18 mar 1985
    Consegnato il 15 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,606.40
    Brevi particolari
    All that property situate at and known as 50 nottingham road, stapleford nottingham title no nt 51870.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Building Society
    Transazioni
    • 15 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 ott 1984
    Consegnato il 26 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 69 high street bagshot surrey title no sy 453934.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 set 1984
    Consegnato il 01 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10 station road, earl shilton leicester title no lt 74505.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 set 1984
    Consegnato il 01 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The cross enderby leicester including all fixtures & fittings (other than trade fixtures a fittings) plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 19 mar 1984
    Consegnato il 20 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from john beynon david william hill and stephen martin welsh to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    42 market place dewsbury kirkless west yorkshire title no wk 130185.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 1983
    Acquisito il 30 ott 1984
    Consegnato il 01 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £80,000
    Brevi particolari
    48/48A high street marlow bucks.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 17 mag 1983
    Consegnato il 19 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from davivd william hill, john beynon and/or midland bank trust company not exceeding ukp 75,000
    Brevi particolari
    42 market pl dewsbury w yorks tn wyk 130186.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 18 gen 1983
    Consegnato il 25 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £122,971.38 due or to become due from midland bank trust company limited to the chargees
    Brevi particolari
    77 parkway london NW1 title nos 421616 ln 53012 ln 53974 413310 431291.
    Persone aventi diritto
    • J.H. Heywood
    • W.F. Mullins
    • A.C.F. Morris
    Transazioni
    • 25 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 ott 1982
    Consegnato il 15 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from midland bank trust company limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 77 parkway london NW1 title nos 421616, ln 53012 ln 53974, 413310 & 413291.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    A registered charge
    Creato il 10 ago 1982
    Acquisito il 09 apr 1984
    Consegnato il 07 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £22750.28
    Brevi particolari
    20 nelson street bradford title no wyk 114486.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1985Registrazione di un'ipoteca

    SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 ago 2016Inizio della liquidazione
    07 mar 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gregory Andrew Palfrey
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    Praticante
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    Stephen John Adshead
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Praticante
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0