CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00830929 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LLOYDS INTERNATIONAL LEASING LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| LBI CREDIT LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| CLARK EQUIPMENT CREDIT LIMITED | 14 dic 1964 | 14 dic 1964 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Scott Mckay Barkman come amministratore in data 08 ott 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 4 pagine | 4.71 | ||||||||||
Cessazione della carica di Pamela Hindley Smith come amministratore in data 22 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Paul Faraday come amministratore in data 25 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 23 Great Winchester Street London EC2P 2AX in data 19 mar 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 20 gen 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vaughan Williams come amministratore in data 21 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Vaughan Williams il 02 apr 2009 | 1 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Scott Mckay Barkman come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTHERFORD, Adam Paul | Segretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Segretario | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
| FLETCHER, Edward Michael | Segretario | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
| HATCHER, Michael Roger | Segretario | Hunyani Ardleigh Road Little Bromley CO11 2QA Manningtree Essex | British | 6759000002 | ||||||
| MASLEN, Frederick Charles Archibald | Segretario | 69 Hayes Hill Hayes BR2 7HN Bromley Kent | British | 3770350001 | ||||||
| O'CONNOR, Sharon Noelle | Segretario | 176 Blagdon Road KT3 4AL New Malden Surrey | Irish | 45487120003 | ||||||
| STAFFORD, Paul Andrew | Segretario | 85 Roman Road IG1 2NZ Ilford Essex | British | 48252270001 | ||||||
| BARKMAN, Scott Mckay | Amministratore | Walden House Road CM9 8PJ Great Totham 1a Essex United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 91404900001 | |||||
| BRADFORD, Valerie Ann | Amministratore | Canfield Park Cottage Canfield Road, Takeley CM22 6ST Bishops Stortford Hertfordshire | British | 74285610001 | ||||||
| CUMMING, Andrew John | Amministratore | 305 Mountjoy House Barbican EC2Y 8BP London | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||
| DAVIES, John Anthony | Amministratore | Westmead Stables Weedon HP22 4NN Aylesbury Buckinghamshire | British | 32423210001 | ||||||
| DAVIES, John Thomas | Amministratore | 2 Hearn Close Tylers Green HP10 8JT Penn Buckinghamshire | British | 2501430001 | ||||||
| DEWDNEY, Andrew David | Amministratore | Cranfield Broad Oak TN12 7NN Benchley Kent | British | 88480180001 | ||||||
| FARADAY, Ian Paul | Amministratore | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | British | 117970910002 | ||||||
| FOAD, Allan Robert | Amministratore | 19 Dukes Orchard DA5 2DU Bexley Kent | British | 40761160001 | ||||||
| FULLELOVE, William Roy | Amministratore | 10 Ennismore Avenue GU1 1SP Guildford Surrey | British | 46128130001 | ||||||
| GREEN, Michael Jonathan | Amministratore | 109 Hampstead Way NW11 7LR London | England | British | 141461000001 | |||||
| HARRISON, David Henry Arnold | Amministratore | Woodcote Lodge West Horsley KT24 6ET Leatherhead Surrey | Uk | British | 8949580001 | |||||
| KING, Roger Steuart | Amministratore | 27 Somerset Square W14 8EE London | Us Citezen | 79713690001 | ||||||
| MILES, Peter Bernard | Amministratore | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | 41327480001 | ||||||
| MILES, Peter Bernard | Amministratore | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | 41327480001 | ||||||
| MOORE, Alan Edward | Amministratore | Flat 2, 20 Wigmore Street W1U 2RQ London | British | 71480200001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Lee Scott | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB Winchester House London United Kingdom | British | 120275570002 | ||||||
| OSBORNE, David Hase | Amministratore | The Manor House Bishops Down Road TN4 8XL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 7602680004 | |||||
| PRITCHARD, David Peter | Amministratore | 17 Thorney Crescent SW11 3TT London | England | British | 57244610001 | |||||
| RIDING, Frederick Michael Peter | Amministratore | York House Clifton Down Road BS8 4AG Clifton Bristol | British | 76317830002 | ||||||
| ROOS, Nicholas Andrew | Amministratore | 2 Claremont Park N3 1TH London | British | 88479620001 | ||||||
| SEGGINS, Roger Russell | Amministratore | Marronwood 4 Kelvedon Avenue KT12 5ED Walton On Thames Surrey | British | 46846030003 | ||||||
| SMITH, Pamela Hindley | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB Winchester House London United Kingdom | British | 38994140002 | ||||||
| TWIDALE, Peter Gordon | Amministratore | 12 Baymans Wood Shenfield CM15 8BT Brentwood Essex | British | 73077810001 | ||||||
| VOWLES, Anthony Brian | Amministratore | Hopgardens Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | 75134410001 | ||||||
| WILLIAMS, Vaughan | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 33495830005 |
CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of covenants | Creato il 13 apr 1989 Consegnato il 17 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 16.9.88 the deed of covenants a charge dated 13.4.89 and any other such documents | |
Brevi particolari Mv 'blackrock' & her engines machinery boats the insurances and her earnings please see doc m 174 for details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Statutory mortgage | Creato il 13 apr 1989 Consegnato il 17 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current regulated by a financial agreement dated 16.9.88 and a deed of covenants dated 13.4.89. | |
Brevi particolari 64/64 shares in mv 'blackrock' register the port of london official no 717140 and in her boats & appurtenances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shipowners agreements | Creato il 16 set 1988 Consegnato il 19 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements dated 16.9.88. | |
Brevi particolari Any moneys payable to the company under the terms of clause 9(b) on 15 (b) of the financial agreement dated 16.9.88. (please see form 395). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Financial agreement | Creato il 16 set 1988 Consegnato il 19 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,560,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £2,560,000. under the terms of the financial agreement dated 16.9.88, the building agreement dated 23.5.88 as movated by a movation agreement dated 21.7.88. | |
Brevi particolari All the company's beneficial interest and all its benefits rights and titles under the contract inc the vessel her machinery equipment and materials, all moneys payable. (Please see form 395 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81 | Creato il 15 apr 1981 Acquisito il 18 set 1981 Consegnato il 09 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Ukd 20,000,000 | |
Brevi particolari Property acquired by lloyds international leasing LTD. From seabord coastt line railroad company:- 200 new 100 ton 60 ft 9 in cuf railroad box cares listed in the us official railay equipment register (the 'register') as scl 9550/95749 inclusive and 237 new 100 ton 7000 cu ft railroad woodchip hopper cars listed in the registerer as scl 196475-196711 inclusive. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81 | Creato il 15 apr 1981 Acquisito il 18 set 1981 Consegnato il 09 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Ukd 20,000,000 | |
Brevi particolari Property acquired by lloyds international leasing LTD from louisville and nashville railroad company:- 100 new 100 ton 4750 cu. Ft. Covered railroad hopper cars listed in the us official railway equipment register (the 'register') as l & n 242600 - 242699 inclusive; and 489 new 100 ton railroad coal hopper cars listed in the register as l & n 551621 - 552109 inclusive. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0