CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED

CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00830929
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LLOYDS INTERNATIONAL LEASING LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    LBI CREDIT LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    CLARK EQUIPMENT CREDIT LIMITED14 dic 196414 dic 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Scott Mckay Barkman come amministratore in data 08 ott 2012

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Cessazione della carica di Pamela Hindley Smith come amministratore in data 22 giu 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Paul Faraday come amministratore in data 25 giu 2012

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 23 Great Winchester Street London EC2P 2AX in data 19 mar 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 feb 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2012

    Stato del capitale al 16 feb 2012

    • Capitale: GBP 9
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 20 gen 2012

    • Capitale: GBP 9.00
    4 pagineSH19

    Cessazione della carica di Vaughan Williams come amministratore in data 21 set 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    11 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Vaughan Williams il 02 apr 2009

    1 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Scott Mckay Barkman come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Segretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    FLETCHER, Edward Michael
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    Segretario
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    British78572640002
    HATCHER, Michael Roger
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    Segretario
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    British6759000002
    MASLEN, Frederick Charles Archibald
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    Segretario
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    British3770350001
    O'CONNOR, Sharon Noelle
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Segretario
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Irish45487120003
    STAFFORD, Paul Andrew
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    Segretario
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    British48252270001
    BARKMAN, Scott Mckay
    Walden House Road
    CM9 8PJ Great Totham
    1a
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    Walden House Road
    CM9 8PJ Great Totham
    1a
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander91404900001
    BRADFORD, Valerie Ann
    Canfield Park Cottage
    Canfield Road, Takeley
    CM22 6ST Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Canfield Park Cottage
    Canfield Road, Takeley
    CM22 6ST Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British74285610001
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    Amministratore
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritish46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British32423210001
    DAVIES, John Thomas
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    British2501430001
    DEWDNEY, Andrew David
    Cranfield
    Broad Oak
    TN12 7NN Benchley
    Kent
    Amministratore
    Cranfield
    Broad Oak
    TN12 7NN Benchley
    Kent
    British88480180001
    FARADAY, Ian Paul
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Amministratore
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    British117970910002
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Amministratore
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British40761160001
    FULLELOVE, William Roy
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    British46128130001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    Amministratore
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritish141461000001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritish8949580001
    KING, Roger Steuart
    27 Somerset Square
    W14 8EE London
    Amministratore
    27 Somerset Square
    W14 8EE London
    Us Citezen79713690001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    MOORE, Alan Edward
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    Amministratore
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    British71480200001
    O'SULLIVAN, Lee Scott
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    British120275570002
    OSBORNE, David Hase
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish7602680004
    PRITCHARD, David Peter
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    Amministratore
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    EnglandBritish57244610001
    RIDING, Frederick Michael Peter
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    Amministratore
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    British76317830002
    ROOS, Nicholas Andrew
    2 Claremont Park
    N3 1TH London
    Amministratore
    2 Claremont Park
    N3 1TH London
    British88479620001
    SEGGINS, Roger Russell
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    British46846030003
    SMITH, Pamela Hindley
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    British38994140002
    TWIDALE, Peter Gordon
    12 Baymans Wood
    Shenfield
    CM15 8BT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    12 Baymans Wood
    Shenfield
    CM15 8BT Brentwood
    Essex
    British73077810001
    VOWLES, Anthony Brian
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    British75134410001
    WILLIAMS, Vaughan
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British33495830005

    CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of covenants
    Creato il 13 apr 1989
    Consegnato il 17 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 16.9.88 the deed of covenants a charge dated 13.4.89 and any other such documents
    Brevi particolari
    Mv 'blackrock' & her engines machinery boats the insurances and her earnings please see doc m 174 for details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Statutory mortgage
    Creato il 13 apr 1989
    Consegnato il 17 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current regulated by a financial agreement dated 16.9.88 and a deed of covenants dated 13.4.89.
    Brevi particolari
    64/64 shares in mv 'blackrock' register the port of london official no 717140 and in her boats & appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Shipowners agreements
    Creato il 16 set 1988
    Consegnato il 19 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements dated 16.9.88.
    Brevi particolari
    Any moneys payable to the company under the terms of clause 9(b) on 15 (b) of the financial agreement dated 16.9.88. (please see form 395).
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 19 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 16 set 1988
    Consegnato il 19 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,560,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £2,560,000. under the terms of the financial agreement dated 16.9.88, the building agreement dated 23.5.88 as movated by a movation agreement dated 21.7.88.
    Brevi particolari
    All the company's beneficial interest and all its benefits rights and titles under the contract inc the vessel her machinery equipment and materials, all moneys payable. (Please see form 395 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81
    Creato il 15 apr 1981
    Acquisito il 18 set 1981
    Consegnato il 09 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Ukd 20,000,000
    Brevi particolari
    Property acquired by lloyds international leasing LTD. From seabord coastt line railroad company:- 200 new 100 ton 60 ft 9 in cuf railroad box cares listed in the us official railay equipment register (the 'register') as scl 9550/95749 inclusive and 237 new 100 ton 7000 cu ft railroad woodchip hopper cars listed in the registerer as scl 196475-196711 inclusive.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Safe Deposit and Trust Company
    Transazioni
    • 09 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 30 dic 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81
    Creato il 15 apr 1981
    Acquisito il 18 set 1981
    Consegnato il 09 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Ukd 20,000,000
    Brevi particolari
    Property acquired by lloyds international leasing LTD from louisville and nashville railroad company:- 100 new 100 ton 4750 cu. Ft. Covered railroad hopper cars listed in the us official railway equipment register (the 'register') as l & n 242600 - 242699 inclusive; and 489 new 100 ton railroad coal hopper cars listed in the register as l & n 551621 - 552109 inclusive.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Safe Deposit and Trust Company
    Transazioni
    • 09 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 30 dic 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 apr 2013Data di scioglimento
    28 feb 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0