NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00835918 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 200 Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARADON PLUMBING HOLDINGS LIMITED | 24 giu 1998 | 24 giu 1998 |
| CARADON BUILDING PRODUCTS LIMITED | 09 nov 1993 | 09 nov 1993 |
| CARADON TRADING LIMITED | 29 ott 1993 | 29 ott 1993 |
| CARADON LIMITED | 22 lug 1987 | 22 lug 1987 |
| CARADON (UK) LIMITED | 27 nov 1985 | 27 nov 1985 |
| REED BUILDING PRODUCTS LIMITED | 29 gen 1965 | 29 gen 1965 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Elizabeth Jane Earle il 01 dic 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB United Kingdom a 200 Berkshire Place Winnersh Triangle Berkshire RG41 5rd | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Jane Earle come amministratore in data 15 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Notifica di Ackermann Limited come persona con controllo significativo il 17 ott 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Novar Holdings Limited come persona con controllo significativo il 17 ott 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB a 200 Berkshire Place Winnersh Triangle Berkshire RG41 5rd in data 13 mar 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashish Kumar Saraf come amministratore in data 26 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Michele Elaine Hudson come amministratore in data 26 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Allan Richards come amministratore in data 26 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 21 Holborn Viaduct London EC1A 2DY United Kingdom a Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 ott 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARLE, Elizabeth Jane | Amministratore | Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle 200 Berkshire | United Kingdom | British | 256881430001 | |||||||||
| HUDSON, Michele Elaine | Amministratore | Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle 200 Berkshire | United Kingdom | British | 251257190001 | |||||||||
| RICHARDS, Allan | Amministratore | Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle 200 Berkshire | England | British | 55171600002 | |||||||||
| BHOWMIK, Chandan Kanti | Segretario | 22 Armour Hill Tilehurst RG31 6JP Reading Berkshire | British | 3752320001 | ||||||||||
| BURNINGHAM, Derek | Segretario | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | 3360080001 | ||||||||||
| ROE, Jeremy James | Segretario | Green Ginger Hook Heath Road GU22 0QE Woking Surrey | British | 3793060001 | ||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
| SISEC LIMITED | Segretario | Holborn Viaduct EC1A 2DY London 21 United Kingdom |
| 38545840001 | ||||||||||
| BHOWMIK, Chandan Kanti | Amministratore | 22 Armour Hill Tilehurst RG31 6JP Reading Berkshire | British | 3752320001 | ||||||||||
| BURNINGHAM, Derek | Amministratore | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | 3360080001 | |||||||||
| BUTLER, Shaun | Amministratore | 43 High Road Cookham SL6 9HR Maidenhead Berkshire | British | 50657570001 | ||||||||||
| CARPENTER, Howard Frederick | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | 155687070001 | |||||||||
| CLARK, Martin | Amministratore | Holwood Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | British | 74396390001 | ||||||||||
| COHEN, Daniel Charles | Amministratore | 25 Berwyn Road TW10 5BP Richmond Surrey | British | 2421540001 | ||||||||||
| FRASER, Grant William | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks | Scotland | British | 127713450002 | |||||||||
| HINTZ, Bernd Jurgen | Amministratore | 9 Lambourne Avenue Wimbledon SW19 7DW London | American | 38172100003 | ||||||||||
| HOLLAND, Anthony Edward | Amministratore | 6 Brooklyn Drive Emmer Green RG4 8SS Reading Berkshire | England | British | 38110900001 | |||||||||
| JANSEN, Peter Johan | Amministratore | Constantia South Road St Georges Hill KT13 0NA Weybridge Surrey | Dutch | 2421570002 | ||||||||||
| LLEWELLYN, Trefor Wilmot | Amministratore | Hill Farm House Ipsden OX10 6AD Wallingford Oxfordshire | England | British | 107250730001 | |||||||||
| LLOYD, Andrew Nigel | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | 76992750001 | |||||||||
| MAINWARING, Paul Richard | Amministratore | 7 Woodlands Park Merrow GU1 2TH Guildford Surrey | England | British | 116302540001 | |||||||||
| MCCORMACK, Stuart Robert | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks | United Kingdom | British | 206977170001 | |||||||||
| MCKEON, Michael James Edward | Amministratore | 4 The Square High Pine Close KT13 9EA Weybridge Surrey | British | 69781170004 | ||||||||||
| MILLS, Robert John Henry | Amministratore | Hacheston Lodge The Street Hacheston IP13 0DL Woodbridge Suffolk | England | British | 62567910001 | |||||||||
| MONKS, Terence John | Amministratore | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | 80344460001 | ||||||||||
| PROTHEROE, David Jason Lloyd | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | 31826530001 | |||||||||
| RICHARDS, Allan | Amministratore | 12 Thistle Grove SW10 9RZ London | England | British | 55171600002 | |||||||||
| ROE, Jeremy James | Amministratore | Green Ginger Hook Heath Road GU22 0QE Woking Surrey | British | 3793060001 | ||||||||||
| SARAF, Ashish Kumar | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks United Kingdom | India | Indian | 225393150001 | |||||||||
| STUART, Ian | Amministratore | Old Smithy Upper Culham RG10 8NR Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 95599700001 | |||||||||
| WALKER, Timothy | Amministratore | Sandhurst Farm Clayhill Road, Lamberhurst TN3 8AX Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 64603310001 | |||||||||
| WHEELER, Simon Crane | Amministratore | Pond Oast Postern Park Farm Postern Lane TN11 0QT Tonbridge Kent | British | 39252030001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackermann Limited | 17 ott 2018 | Berkshire Place Winnersh Triangle RG41 5RD Wokingham 200 Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Novar Holdings Limited | 06 apr 2016 | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composit guarantee & debenture | Creato il 24 nov 1986 Consegnato il 27 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein samuel montagu & co limited as agent the banks as defined therein and midland bank PLC. On any account whatsoever. | |
Brevi particolari See doc for fuller details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Compsite guarantee & debenture | Creato il 23 ott 1985 Consegnato il 06 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Creato il 23 ott 1985 Consegnato il 06 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0