TL RISK SOLUTIONS LIMITED

TL RISK SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTL RISK SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00838046
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOWRY LAW INSURANCE BROKERS LIMITED27 giu 199227 giu 1992
    TOWRY LAW(GENERAL INSURANCE) LIMITED17 feb 196517 feb 1965

    Quali sono gli ultimi bilanci di TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Hexagon House Grimbald Crag Close St James Business Park Knaresborough North Yorkshire HG5 8PJ a 15 Canada Square London E14 5GL in data 11 dic 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 nov 2018

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 03 ago 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 03 ago 2018

    2 pagineAP03

    Soddisfazione dell'onere 008380460010 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Antonios Erotocritou come amministratore in data 02 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Mugge come amministratore in data 02 mar 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Nomina di Mr David Christopher Ross come amministratore in data 20 dic 2016

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mrs Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 20 dic 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 20 dic 2016

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 20 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jennifer Owens come segretario in data 01 mar 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2016

    Stato del capitale al 15 gen 2016

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Stephen Mugge il 25 nov 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Scott Egan come amministratore in data 14 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Stephen Mugge come amministratore in data 11 set 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    249087020001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrishDirector222326970001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    169015530001
    GIFFORD, Nicola Jane
    Grimbald Crag Close
    St James Busienss Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Grimbald Crag Close
    St James Busienss Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor134774840001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    Segretario
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    207682870001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    Segretario
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    221919790001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    8 Wynches Farm Drive
    AL4 0XH St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    8 Wynches Farm Drive
    AL4 0XH St Albans
    Hertfordshire
    British57375770002
    HALE, Julie Kathryn
    20 Saint Francis Gardens
    Fixby
    HD2 2EU Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    20 Saint Francis Gardens
    Fixby
    HD2 2EU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector67342760001
    OWENS, Jennifer
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    183285340001
    PETERS, Christopher Robert James
    6 Greenham Close
    Woodley
    RG5 4EG Reading
    Berkshire
    Segretario
    6 Greenham Close
    Woodley
    RG5 4EG Reading
    Berkshire
    British1149980001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Segretario
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    BritishCompany Secretary6180280001
    SORKIN, Alan
    16 Fir Tree Close
    HP3 8NG Leverstock Green
    Herts
    Segretario
    16 Fir Tree Close
    HP3 8NG Leverstock Green
    Herts
    British33027210001
    WATSON, Gerald Alistair
    43 Abbotts Grove
    Werrington
    PE4 5BP Peterborough
    Segretario
    43 Abbotts Grove
    Werrington
    PE4 5BP Peterborough
    British47729060001
    WEBB, Keith
    Homelands New Park Road
    GU6 7HJ Cranleigh
    Surrey
    Segretario
    Homelands New Park Road
    GU6 7HJ Cranleigh
    Surrey
    British60362380002
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishCompany Director79136250001
    BLACK, Douglas Buller
    37 Sussex Street
    SW1V 4RJ London
    Amministratore
    37 Sussex Street
    SW1V 4RJ London
    BritishAccountant43854840001
    BLANC, Amanda Jayne
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95215560001
    BOYD, Robert
    Crackley Hill
    Coventry Road
    CV8 2FP Kenilworth
    16
    Warwickshire
    Amministratore
    Crackley Hill
    Coventry Road
    CV8 2FP Kenilworth
    16
    Warwickshire
    BritishDirector129768660001
    CASSEY, Simon Barrie
    Hillside
    Upper Swanmore, Swanmore
    SO32 2QQ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Hillside
    Upper Swanmore, Swanmore
    SO32 2QQ Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director69489660001
    COOPER, Roger Henry Edward
    2 Wolsey Road
    Moor Park
    HA6 2HS Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    2 Wolsey Road
    Moor Park
    HA6 2HS Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector1149970002
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector59873490009
    EGAN, Scott
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector169274290001
    ELLIS, Paul Grant
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishInsurance Broker8400580001
    FISHER, Andrew Charles
    Barngates Lodge, Church Lane
    Binfield
    RG42 5NS Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Barngates Lodge, Church Lane
    Binfield
    RG42 5NS Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector107491560001
    HALE, Julie Kathryn
    20 Saint Francis Gardens
    Fixby
    HD2 2EU Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    20 Saint Francis Gardens
    Fixby
    HD2 2EU Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector67342760001
    HODGES, Mark Steven
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector58444370003
    HOMER, Andrew Charles
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector13483140003
    HUTCHINSON, David Anthony
    28 Moorland Drive
    LS17 6JP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    28 Moorland Drive
    LS17 6JP Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director4201380001
    KERRY, Brian
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector114108280001
    LAW, Cecil Towry Henry, The Rt Hon
    6 Sussex Square
    W2 2SJ London
    Amministratore
    6 Sussex Square
    W2 2SJ London
    BritishCompany Director1260390001
    LAW, Nigel Frederick
    7 Hollingwood Gate
    LS29 9PP Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Hollingwood Gate
    LS29 9PP Ilkley
    West Yorkshire
    BritishInsurance Broker112312120001
    LYONS, Alastair David
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishExecutive Chairman193428270001
    MARTIN, Kim Ian
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishInsurance Director11165290001
    MUGGE, Mark Stephen
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HG5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector162920630005

    Chi sono le persone con controllo significativo di TL RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Townfrost Limited
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HP5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Grimbald Crag Close
    St James Business Park
    HP5 8PJ Knaresborough
    Hexagon House
    North Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione05030455
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TL RISK SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 apr 2015
    Consegnato il 22 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transazioni
    • 22 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 mag 2013
    Consegnato il 21 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2012
    Consegnato il 06 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 feb 2011
    Consegnato il 25 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 25 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 08 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 gen 2000
    Consegnato il 25 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security and trust deed
    Creato il 29 gen 1990
    Consegnato il 13 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the creditors for the time being of the company in respect of insurance trnasactions under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (see form 395 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's (A Statutory Corporation)
    Transazioni
    • 13 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 03 apr 1984
    Consegnato il 06 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold godolphin court, stoke poges lane, slough, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 03 apr 1984
    Consegnato il 04 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Godolphin court, off stoke poges lane, slough, berks. Together with all fixtures, fittings, plant, machinery, apparatus, goods & materials (not being personal chattels with the bills of sale acts 1878 to 1882 & not being tenants fixtures on fittings).
    Persone aventi diritto
    • Royal Life Insurance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 23 feb 1983
    Consegnato il 04 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that the company's right, title & interest in the monies standing to the credit of the companies "c" account at the date of the trust deed & in the monies & investments at the date of the trust deed standing to the credit of or held in other iba accounts of the company from any source (full details doc 1961 refers).
    Persone aventi diritto
    • The Corporation of Lloyds
    Transazioni
    • 04 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TL RISK SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 nov 2018Inizio della liquidazione
    06 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0