CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED

CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLAVERHAM HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00839154
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLAVERHAM LIMITED09 giu 199909 giu 1999
    F H LIMITED26 gen 199826 gen 1998
    FAIREY HYDRAULICS LIMITED26 feb 196526 feb 1965

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:res re statement of account
    1 pagineLIQ MISC RES

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Claverham Limited Bishops Road Claverham BS49 4NF

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Claverham Bristol BS49 4NF a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 05 set 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di Mr Evan Francis Smith come amministratore in data 15 lug 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christian Bruno Jean Idczak-Descat come amministratore in data 15 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andreas Schell come amministratore in data 15 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Rajinder Singh Kullar come amministratore in data 15 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Andrew Fowler come amministratore in data 15 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2014

    Stato del capitale al 07 mag 2014

    • Capitale: GBP 1.000004
    SH01

    Cessazione della carica di Roger Robert Charles Buxton come amministratore in data 06 apr 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 nov 2012

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 giu 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 25/06/2013
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 mag 2013

    • Capitale: GBP 500,002
    4 pagineSH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 mag 2013

    • Capitale: GBP 500,001.00
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Andreas Schell come amministratore in data 19 feb 2013

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDWIN COE SECRETARIES LIMITED
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneOC326366
    139112420001
    IDCZAK, Christian Bruno Jean
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandFrench129935690010
    KULLAR, Rajinder Singh
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Untied KingdomBritish74999290008
    SMITH, Evan Francis
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican,Irish73647690004
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Segretario
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    BUTTERWORTH, Philip
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    Segretario
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    British75347870001
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Segretario
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    British77864400001
    HUTCHINGS, Mark Alexander
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    Segretario
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    British57349970001
    MCCARTHY, Richard Thomas
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    Segretario
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    American128751220001
    PACKHAM, Robert William
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    Segretario
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    British137923770001
    ANTHONY, Michael John
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    British41660490001
    ANTHONY, Michael John
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    British41660490001
    BEAN, Alan David
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    Amministratore
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    British66656720002
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Amministratore
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    BROWN, Trevor Ambrose
    Romana 12 Knole Park
    Almondsbury
    BS12 4BS Bristol
    Amministratore
    Romana 12 Knole Park
    Almondsbury
    BS12 4BS Bristol
    British37438480002
    BUTTERWORTH, Philip
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    Amministratore
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    EnglandBritish75347870001
    BUXTON, Roger Robert Charles
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    Amministratore
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    United KingdomBritish78210300002
    CALDERBANK, Martin Nicholas
    2 Burleigh Place
    SW15 6ES London
    Amministratore
    2 Burleigh Place
    SW15 6ES London
    British66234230001
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Amministratore
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    EnglandBritish77864400001
    FOWLER, Peter Andrew
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    Amministratore
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    United KingdomBritish241110830001
    FROST, Simon Richard
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    British87291390001
    GARDINER, Michael Charles
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    Amministratore
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    United KingdomUk172073870001
    GINGRICH, James Lee
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Amministratore
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Us Citizen77865030001
    GUTTRIDGE, Nicholas James
    The Manor
    BS39 5AN Hinton Blewett
    North Somerset
    Amministratore
    The Manor
    BS39 5AN Hinton Blewett
    North Somerset
    EnglandBritish27456810004
    HUTCHINGS, Mark Alexander
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    Amministratore
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    British57349970001
    KINGSBURY, Derek John
    Sparnal Stitch
    Trewint Lane Rock
    PL27 6LU Wadebridge
    Cornwall
    Amministratore
    Sparnal Stitch
    Trewint Lane Rock
    PL27 6LU Wadebridge
    Cornwall
    British18255570002
    LEDUC, Robert Francis
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    Amministratore
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    UsaUs Citizen103629560001
    MCDONALD, Mark
    10 The Fielders
    Worle
    BS22 7HH Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    10 The Fielders
    Worle
    BS22 7HH Weston Super Mare
    Avon
    British103638740001
    MITCHELL, Henry George
    1 Bruddel Grove
    SN3 1PW Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    1 Bruddel Grove
    SN3 1PW Swindon
    Wiltshire
    British8307520002
    PAGE, Stephen John
    Orchard Hse
    Titlands Lane, Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    Amministratore
    Orchard Hse
    Titlands Lane, Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    British92689630001
    POULTER, John William
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    British4333730002
    SAXE, Thomas William
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    Amministratore
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    UsaAmerican155680740001
    SCHELL, Andreas
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    UsaGerman176150890001
    SYMONDS, Philip Gerard
    Boundary Cottage
    Fen Pond Road Ightham
    TN15 9JF Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Boundary Cottage
    Fen Pond Road Ightham
    TN15 9JF Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish38887120002
    TAYLOR, David John
    Fairlie Lawn
    Sidcot Lane
    BS25 1LP Winscombe
    Avon
    Amministratore
    Fairlie Lawn
    Sidcot Lane
    BS25 1LP Winscombe
    Avon
    British27456820001

    CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of offset (executed by the company formerly known as fairey hydraulics limited)
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 06 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the "principal debtors" (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and all other charges and expenses subject at all times to the provisions of the senior finance documents (as defined in the facilities agreement dated 23 january 1998 (as defined))
    Brevi particolari
    All moneys at the date of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books by way of fixed and specific charge.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 06 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as fairey hydraulics limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 06 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 16 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and all moneys due from fairey group limited on any account whatsoever toe security pacific ever of maince (U.K.) limited
    Brevi particolari
    F/Hold pieces or parcels of land situate at claversham in the county of avon with factory buildings messuagge outbuildings and premises erected thereon and k/as court de wyck tannery claverham 9.938 acres or the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures see doc M33/17JUL/lh.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Ever of Maince (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 gen 1987
    Consegnato il 04 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from fairey group limited to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the loan agreement dated 31/12/86 and for securing all moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and/or all or any of the other companies named therein to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the aforesaid loan agreement dated 31/12/1986
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all those freehold pieces of land or parcels of land situate at claverham in the county of avon with the factory building message outbuildings and premises known as court-de-wyck, tannery, claverham. A specific equitable charge over all freehold and lease hold property fixed and floating charge over all debts and other sums, benefits of all securities, stocks, shares goodwill, uncalled capital. Patents, trademarks, copyrights undertaking and assets (see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and All Banks Which May from Time to Time Be Joined as Parties to the Loan Agreement.
    Transazioni
    • 04 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 16 gen 1987
    Consegnato il 27 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over f/h land with factory building messuage and buildings and premises erected thereon and known as court-de-wyer tarmery, claveham, having on area of 9.938 acres or thereabouts and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1987Registrazione di un'ipoteca

    CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 ago 2014Inizio della liquidazione
    05 giu 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0