TURBOFLEX LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TURBOFLEX LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00839728 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TURBOFLEX LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TURBOFLEX LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o BIBBY TRANSMISSIONS Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TURBOFLEX LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per TURBOFLEX LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 29 dic 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 04 dic 2017
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Carl Richard Christenson il 10 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Graham Varga come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Richard Ian Laws come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Penelope Turvey come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
Nomina di Graham Varga come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TURBOFLEX LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWS, Richard Ian | Segretario | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | 182626840001 | |||||||
| CHRISTENSON, Carl Richard | Amministratore | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | United States | American | 110880800002 | |||||
| STORCH, Christian | Amministratore | 12 Preston Square Quincy Massachusetts Ma 02171 United States | United States | German | 126884910001 | |||||
| AGOCS, Stephen Francis | Segretario | 128 Upper Ferry Road Trenton New Jersey FOREIGN Usa | American | 34721300001 | ||||||
| BALDREY, Philip Nigel | Segretario | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | British | 44039650003 | ||||||
| BIRD, Thomas Joseph | Segretario | 1211 Karen Lane 19087 Radnor Pennsylvania Usa | Usa | 33616600001 | ||||||
| BUCKLEY, Deryck Stephen | Segretario | 9 Halifax Road Staincliffe WF13 4AA Dewsbury West Yorkshire | British | 47883800001 | ||||||
| COOPER, James Sidney William | Segretario | 11 The Croft Meriden CV7 7NQ Coventry | British | 33253280001 | ||||||
| FITZPATRICK, Stephen Joseph | Segretario | The Maltings Carlton-On-Trent NG23 6NS Newark Nottinghamshire | British | 204911280005 | ||||||
| HALE, Vivien Joan | Segretario | Keeley 12 Gables Meadow Holmer Green HP15 6RT High Wycombe Buckinghamshire | British | 56115110001 | ||||||
| HALLAM, Peter Leslie | Segretario | 25 Cambridge Road PE9 1BN Stamford Lincolnshire | British | 2258630001 | ||||||
| HARRISON, Brian | Segretario | 16 Briarwood Road GU21 1XD Woking Surrey | British | 13648350001 | ||||||
| TURVEY, Penelope Ann | Segretario | 182 High Street PE19 6SD Yelling Cambs | British | 103094630002 | ||||||
| VARGA, Graham | Segretario | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | British | 168160770001 | ||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Segretario | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||
| ABLITT, Ivor Geoffrey | Amministratore | 15 Tattershall Drive Market Deeping PE6 8BS Peterborough Cambridgeshire | British | 3848360001 | ||||||
| AGOCS, Stephen Francis | Amministratore | 128 Upper Ferry Road Trenton New Jersey FOREIGN Usa | American | 34721300001 | ||||||
| BALDREY, Philip Nigel | Amministratore | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | England | British | 44039650003 | |||||
| BUCKLEY, Deryck Stephen | Amministratore | 9 Halifax Road Staincliffe WF13 4AA Dewsbury West Yorkshire | British | 47883800001 | ||||||
| BURDETT, Roger Leonard | Amministratore | 2 Pennyfields Boulevard NG10 3QJ Long Eaton Nottinghamshire | British | 53792200005 | ||||||
| BURDETT, Roger | Amministratore | Yew Tree Cottage Mill Lane Lapworth B94 6HT Solihull West Midlands | British | 53792200004 | ||||||
| BURNS, Christopher Peter | Amministratore | Peters Farm Sulgrave Road Helmdon NN13 5QH Brackley Northamptonshire | British | 29017860001 | ||||||
| COOPER, James Sidney William | Amministratore | 11 The Croft Meriden CV7 7NQ Coventry | British | 33253280001 | ||||||
| FITZPATRICK, Stephen Joseph | Amministratore | The Maltings Carlton-On-Trent NG23 6NS Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | 204911280005 | |||||
| FOX, David John | Amministratore | 58 North End Road Quainton HP22 4BG Aylesbury Buckinghamshire | British | 4519410001 | ||||||
| HALE, Vivien Joan | Amministratore | Keeley 12 Gables Meadow Holmer Green HP15 6RT High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 56115110001 | |||||
| HERBAGE, Bernard Stanley | Amministratore | Tanglewood Lodge Sycamore Road HP6 6BB Amersham Buckinghamshire | British | 36629450001 | ||||||
| HOCKLEY, Donald Keith | Amministratore | 6 East Ridge SL8 5BX Bourne End Buckinghamshire | British | 13685820001 | ||||||
| KEITH, Percival Cleveland | Amministratore | 1 Turvey Close Aston Clinton HP22 5JG Aylesbury Buckinghamshire | American | 13648320001 | ||||||
| LEWIS, Brian | Amministratore | The Hyde Mountnessing Road Blackmore CM4 0NX Ingatestone Essex | British | 18905160001 | ||||||
| LOVE, Colin Wilson | Amministratore | 3 Andrews Way Raunds NN9 6RD Wellingborough Northamptonshire | British | 65767530002 | ||||||
| MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham | Amministratore | The Hatch Gaunts Common BH21 4JB Wimborne Dorset | England | English | 13447260001 | |||||
| MCKELLER, Lawson | Amministratore | 122 Sheerstock HP17 8EX Haddenham Buckinghamshire | British | 40188720001 | ||||||
| MIDSON, Anthony John | Amministratore | 27 Wymering Road HP21 9BP Aylesbury Buckinghamshire | British | 13685830001 | ||||||
| RODGER, David Anthony Hugh | Amministratore | Oaktrees Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | British | 89739630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TURBOFLEX LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibby Transmissions Limited | 14 dic 2016 | Cannon Way WF13 1EH Dewsbury Bibby Transmissions Ltd West Yorkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TURBOFLEX LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 08 mar 2007 Consegnato il 10 mar 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 lug 2000 Consegnato il 25 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 lug 2000 Consegnato il 25 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the mezzanine documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge | Creato il 27 mar 1997 Consegnato il 08 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future sums, liabilities or obligations from time to time due, owing or incurred (actually or contingently) by chargeready limited (the principal borrower) or any other group company to the chargee as agent and security trustee for the beneficiaries (as defined) under or in connection with the facilities agreement (as defined) and/or any other senior finance document (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts patents buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over stocks shares or other securities | Creato il 11 feb 1994 Consegnato il 28 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a mortgage debenture dated 28 may 1993 | |
Brevi particolari A specific charge over all stocks shares or other securities in any subsidiary companies or any other company for the time being. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over credit balances | Creato il 01 ott 1993 Consegnato il 21 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The sum of £32,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 83557997 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 28 mag 1993 Consegnato il 08 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0