BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00842309 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
- Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione
Dove si trova BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EMAP LONDON LIFESTYLE LIMITED | 29 apr 2003 | 29 apr 2003 |
| EMAP ELAN NETWORK LIMITED | 08 feb 2000 | 08 feb 2000 |
| EMAP ELAN LIMITED | 16 mag 1990 | 16 mag 1990 |
| GREEN LANE PUBLISHING COMPANY LIMITED | 29 ott 1986 | 29 ott 1986 |
| GREEN LANE TRAVEL(AIR AND SHIPPING)LIMITED | 23 mar 1965 | 23 mar 1965 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 ott 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Giles Robert Nasmyth Cooper come amministratore in data 19 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tina Sany Davies come amministratore in data 19 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 25 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Tina Sany Davies il 25 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Keenan il 25 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Giles Robert Nasmyth Cooper il 25 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Bauer Group Secretariat Limited il 25 set 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 30 set 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 14 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Lincoln Court Lincoln Road Peterborough PE1 2RF a Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA in data 01 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Segretario | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England |
| 159023720001 | ||||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | 243390510001 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | 119137220004 | |||||||||
| ELSDON, Kate | Segretario | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Segretario | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||||||
| HENSON, Mark Richard | Segretario | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||||||
| HOGG, Marianne Lisa | Segretario | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | 101383970002 | ||||||||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Segretario | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Segretario | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 127932350001 | |||||||||||
| ANDERS, Philip William | Amministratore | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | England | British | 42645630003 | |||||||||
| ARCULUS, Thomas David Guy | Amministratore | Flat 193 County Hall North Block 1a Belvedere Road SE1 7GH London | British | 80344070001 | ||||||||||
| BARKER, Caroline Jane | Amministratore | Bailiffs Cottage Tatmore Place SG4 7QR Gosmore, Hitchin Herts., | British | 68526560001 | ||||||||||
| BEBE, Dawn Marie | Amministratore | 130 Fawe Park Road Putney SW15 2EQ London | British | 70898930001 | ||||||||||
| BIRCH, Ian | Amministratore | 15 The Avenue N10 2QE London Uk | United Kingdom | British | 68530390002 | |||||||||
| BUTLER, Gillian Carol | Amministratore | Manor Cottage The Common Bookham KT23 3HZ Leatherhead Surrey | British | 76600070001 | ||||||||||
| COOPER, Giles Robert Nasmyth | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | 180256930002 | |||||||||
| DAVIES, David John | Amministratore | 5 Canonbury Park South Islington N1 2JR London | British | 71280830002 | ||||||||||
| GULLIFORD, Simon James | Amministratore | Greenacre 89 High Street Kimpton SG4 8QL Hitchin Hertfordshire | England | British | 30970560002 | |||||||||
| HAND, Kevin Lawrence | Amministratore | 1 The Village Orton Longueville PE2 7DN Peterborough Cambridgeshire | British | 5022630001 | ||||||||||
| HAWKEN, Susan Anne | Amministratore | 4 Strafford Road Twickenham TW1 3AE London | British | 38690900003 | ||||||||||
| HEPWORTH, David | Amministratore | 48 The Mall N14 6LN Southgate London | England | British | 79801940001 | |||||||||
| HOLMAN, Louise Olga Cale | Amministratore | 239 Lonsdale Road Barnes SW13 9QN London | British | 53281320004 | ||||||||||
| KEENAN, Paul | Amministratore | 19 Church Crescent Muswell Hill N10 3NA London | England | British | 39692770003 | |||||||||
| LATHAM, Dorothy | Amministratore | Whittlewood Barn 4a Little London Silverstone NN12 8UP Towcester Northamptonshire | British | 16101680001 | ||||||||||
| LLEWELLYN, Christopher | Amministratore | 385 Harborne Road Edgbaston B15 3LB Birmingham | British | 15113700012 | ||||||||||
| MARRIOTT, Keith | Amministratore | The Sheiling 20 Nene Way Sutton PE5 7XD Peterborough Cambridgeshire | British | 5022640002 | ||||||||||
| MCALEENAN, Patrick David | Amministratore | 78 Hazlewell Road Putney SW15 6UR London | England | British | 14226510001 | |||||||||
| MCILHENEY, Barry Wilson | Amministratore | 27 Kersley Road Stoke Newington N16 0NT London | British | 42477260001 | ||||||||||
| MCILHENEY, Barry Wilson | Amministratore | 27 Kersley Road Stoke Newington N16 0NT London | British | 42477260001 | ||||||||||
| MCINTOSH, Fiona Elizabeth | Amministratore | 7 Wroughton Road SW11 6BE London | Australian | 107210800001 | ||||||||||
| MOLONEY, Thomas Charles | Amministratore | 20 Queen Elizabeths Walk N16 0HX London | United Kingdom | British | 15672060004 | |||||||||
| RICH, Marcus Alvin | Amministratore | Moor End Great Sampford CB10 2RQ Saffron Walden Whitehouse Essex | United Kingdom | British | 156496600001 | |||||||||
| RICH, Marcus Alvin | Amministratore | 38 Chapel Hill Stansted CM24 8AG Essex | British | 85651930001 | ||||||||||
| SANY DAVIES, Tina | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | 180256580002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Consumer Media Limited | 06 apr 2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BAUER LONDON LIFESTYLE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 31 ott 1975 Consegnato il 05 mar 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 27A, the broadway, badley, leicester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 19 dic 1974 Consegnato il 02 gen 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 201 uppingham road leicester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0