MISYS B & S DIVISION LIMITED

MISYS B & S DIVISION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMISYS B & S DIVISION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00844354
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    APRICOT COMPUTERS P.L.C.13 ago 198513 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    11 pagineAA

    Nomina di Mrs Elizabeth Mary Collins come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Director Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanna Hawkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Sanjay Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 16 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2013

    Stato del capitale al 02 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 16 ago 2012

    16 pagineRP04

    Nomina di Thomas Edward Timothy Homer come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Joanna Marageret Hawkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bijal Patel come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Bijal Mahendra Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Farrimond come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Note
    DataNota
    27 ago 2013A second filed AR01 was registered on 27/08/2013

    Nomina di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sarah Brain come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    Segretario
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    146626180001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Segretario
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    170448780001
    BURY, Lindsay Claude Neils
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    Amministratore
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish67103750001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    FOSTER, Roger Keith
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    Amministratore
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    EnglandBritish2551760001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HARFORD, John Timothy, Sir
    South House
    South Littleton
    WR11 5TJ Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    South House
    South Littleton
    WR11 5TJ Evesham
    Worcestershire
    British15932250001
    HART, Michael John
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    Amministratore
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    British118672700001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JONES, Miah Gwynfor
    Box Farm Reynoldston
    SA3 1AA Swansea
    Amministratore
    Box Farm Reynoldston
    SA3 1AA Swansea
    British66161140001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MACPHERSON, Philip Strone Stewart
    Armsworth Park House
    Armsworth Park
    SO24 9RH Old Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Armsworth Park House
    Armsworth Park
    SO24 9RH Old Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish42864500001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Amministratore
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NEWTON, Richard Paul
    21 Priory Road
    Edgbaston
    B5 7UG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    21 Priory Road
    Edgbaston
    B5 7UG Birmingham
    West Midlands
    British2551790001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PEDDER, Clive Thomas
    Chuck Hatch House
    Chuck Hatch
    TN7 4EX Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    Chuck Hatch House
    Chuck Hatch
    TN7 4EX Hartfield
    East Sussex
    United KingdomBritish71955460001
    SOLOMONS, Anthony Nathan
    10 Constable Close
    NW11 6TY London
    Amministratore
    10 Constable Close
    NW11 6TY London
    United KingdomBritish8116770001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Amministratore
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002
    WINN, Christopher
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish15932260001

    MISYS B & S DIVISION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 22 giu 1993
    Consegnato il 01 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility letter, the guarantee and/or the counter indemnity
    Brevi particolari
    All the company's rights to receive payment for or in respect of the new ordinary shares as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trade marks mortgage
    Creato il 05 mar 1990
    Consegnato il 20 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All trade marks of the company. (See form M525C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 mar 1990
    Consegnato il 20 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 14 ago 1986
    Consegnato il 16 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 11 february 1986.
    Brevi particolari
    Leasehold property known as and being ground & upper basement floors 18/19 pall mall london SW1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 17 feb 1986
    Consegnato il 20 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1.513 hectares at rutherford rd, southfield industrial estate, glenrothes, fife with factory buildings thereon k/a 29 rutherford road, glenrothes. 0.340 hectare comprising car park at rutherford road, southfield industrial estate.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 feb 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The research and development centre at vincent drive, edgbaston, b'ham. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment and of present and future copyright by way of security charge
    Creato il 11 feb 1986
    Consegnato il 14 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The charged rights is defined to mean all the copyrights, rights in the nature of copyright and other rights, causes of action and interests assured assigned or charged. For fuller details see doc M78.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 14 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge over goodwill trademarks & tradenames.
    Creato il 11 feb 1986
    Consegnato il 14 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any accounts whatsoever.
    Brevi particolari
    "The charged rights is defined to mean all trademarks, applications for trademarks, tradenames and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. For fuller details see DOCM77.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 14 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Assignment and of patents by way of security charge
    Creato il 11 feb 1986
    Consegnato il 14 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The charged rights is defined to mean all patents patent applications and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. See doc M76 for fuller details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks.
    Transazioni
    • 14 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Assignment and of registered designs by way of security charge
    Creato il 11 feb 1986
    Consegnato il 14 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The charged rights is defined to mean all registered designs applications for registered designs and other rights causes of action and interests assured assigned or charged. For further details see doc M75.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 14 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 feb 1986
    Consegnato il 12 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures see doc M74 for fuller details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 12 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 22 lug 1985
    Consegnato il 23 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Act house, 111 hagley road, edgbaston, birmingham, w mids t/n wk 50832.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Letter of charge
    Creato il 10 giu 1985
    Consegnato il 26 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank (whether in the name of the company or not) on the company's behalf with some 3RD party for the deposit of moneys of the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1985
    Consegnato il 18 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Elizabeth house 17 westbourne road, and the lodge 17A, westbourne road, edgbaston, w midlands. T/n WM28511 wm 312841.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 set 1983
    Consegnato il 05 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H 111 hagley road edgbaston birmingham title no wk 50832.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 05 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1983
    Consegnato il 19 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property situate at & known as shenstone house, halesowen west midlands.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 19 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 24 set 1980
    Consegnato il 06 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1980Registrazione di un'ipoteca

    MISYS B & S DIVISION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 lug 2014Data di scioglimento
    19 dic 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0