MANBRIG PROPERTIES
Panoramica
| Nome della società | MANBRIG PROPERTIES |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 00848103 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MANBRIG PROPERTIES?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova MANBRIG PROPERTIES?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MANBRIG PROPERTIES?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MANBRIG PROPERTIES LIMITED | 07 mag 1965 | 07 mag 1965 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MANBRIG PROPERTIES?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MANBRIG PROPERTIES?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 10 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Bld Property Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 03 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 03 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Ndiana Ekpo come segretario in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Benjamin Toby Grose come amministratore in data 13 lug 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Michael John Forshaw il 20 ago 2013 | CH01 | |||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MANBRIG PROPERTIES?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| CHIA, Swee Ming | Segretario | 10 Mount Ephraim Road Streatham SW16 1NG London | British | 57837290001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | Other | 138446320001 | ||||||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Segretario | 80 Kingsley Way N2 0EN London | British | 3470530003 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| DAVIDSON, Emanuel Wolfe | Amministratore | 6 Beechworth Close NW3 7UT London | United Kingdom | British | 3470540001 | |||||||||
| DAVIDSON, Gerald Abraham | Amministratore | Gardnor House Flask Walk NW3 1HT London | United Kingdom | British | 35563210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Amministratore | 80 Kingsley Way N2 0EN London | England | British | 3470530003 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| RANGER, Patrick | Amministratore | 2 Park Hill Ealing W5 2JR London | England | British | 80021100001 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 | |||||||||
| VANDEVIVERE, Jean-Marc | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | 170947050001 | |||||||||
| WEBB, Nigel Mark | Amministratore | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | 58059360001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MANBRIG PROPERTIES?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bld Property Holdings Limited | 15 ago 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Bld Property Holdings Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MANBRIG PROPERTIES ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 09 set 1970 Consegnato il 16 set 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1, 34A, 36A, 36B, 38A, 40A, 42, 42A, 44 & 44A, geldeston road, london. E.5. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 apr 1970 Consegnato il 20 apr 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 16, leopold road, london, NW10. Title no. Mx 54606. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 27 ago 1969 Consegnato il 02 set 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 21, kylemore rd, camden london - ln 152655, with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 31 mar 1969 Consegnato il 09 apr 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 18 eldon road, london. W. 8. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of whole | Creato il 13 feb 1969 Consegnato il 19 feb 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc. | |
Brevi particolari 8, 14 & 16 sheringham avenue, east ham, newham, title no. 59523. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 nov 1967 Consegnato il 19 dic 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc. | |
Brevi particolari Fixed & floating charge. See doc 19.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 nov 1967 Consegnato il 19 dic 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc, | |
Brevi particolari 38, sheringham avenue, eastham, london,efixed & floating charge. See doc 15.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 nov 1967 Consegnato il 19 dic 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due etc. | |
Brevi particolari Fixed & floating charge. See doc. 14.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 nov 1967 Consegnato il 19 dic 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc. | |
Brevi particolari 2, eastbourne road, haringey, london, N.fixed & floating charge. See doc 13.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0