EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED

EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00852171
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 11th Floor the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT United Kingdom a 79 Caroline Street Birmingham B3 1UP in data 11 dic 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 dic 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Dettagli del direttore cambiati per Garry Elliot Barnes il 12 set 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da The Colemore Building Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT England a 11th Floor the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT in data 21 mar 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Fleet Place London EC4M 7rd England a The Colemore Building Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT in data 01 nov 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Nomina di Garry Elliot Barnes come amministratore in data 03 ott 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonathon Colin Fyfe Crawford come segretario in data 12 set 2016

    2 pagineAP03

    Nomina di Jonathon Colin Fyfe Crawford come amministratore in data 12 set 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin William Donnelly come segretario in data 12 set 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Geoffrey Damien Morgan come amministratore in data 12 set 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew William Hughes come amministratore in data 12 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin William Donnelly come amministratore in data 12 set 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    Segretario
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    214011710001
    BARNES, Garry Elliot
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Amministratore
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    United KingdomBritish215490920001
    CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    Amministratore
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    United KingdomAustralian214009850001
    MORGAN, Geoffrey Damien
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    Amministratore
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    United KingdomBritish214010060001
    DONNELLY, Kevin William
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Segretario
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Usa73249300002
    FORREST, Arthur Thomas
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    Segretario
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    British8427680001
    TRANTER, John
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    Segretario
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    British34350840002
    BEESON, Richard
    Percuil 24 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Percuil 24 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    British44855910004
    BREADY, Richard Lawrence
    166 President Avenue
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    Amministratore
    166 President Avenue
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    UsaAmerican70952970001
    COONEY, Edward Joseph
    Kennedy Plaza
    02903 Providence
    50
    Ri
    Usa
    Amministratore
    Kennedy Plaza
    02903 Providence
    50
    Ri
    Usa
    UsaUnited States161515520001
    DONNELLY, Kevin William
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Amministratore
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Massachusetts UsaUsa73249300002
    DONNELLY, Kevin William
    11 Foxhunt Trail
    Walpole
    Massachusetts
    02081
    Usa
    Amministratore
    11 Foxhunt Trail
    Walpole
    Massachusetts
    02081
    Usa
    American73249300001
    FITTON, Andrew Charles
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    British7527160002
    FORREST, Arthur Thomas
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    EnglandBritish8427680001
    HALL, Almon Charles
    50 Kennedy Plaza
    02903 Providence
    Nortek Inc.
    Rhode Island
    Usa
    Amministratore
    50 Kennedy Plaza
    02903 Providence
    Nortek Inc.
    Rhode Island
    Usa
    United States Of AmericaAmerican177890560001
    HUGHES, Matthew William, Mr.
    Exchange Street
    02903 Providence
    500
    Ri
    Usa
    Amministratore
    Exchange Street
    02903 Providence
    500
    Ri
    Usa
    UsaAmerican203597150001
    MARTIN, Gary Trevor
    34 Beauport Home Farm Close
    TN37 7BW St Leonards-On-Sea
    East Sussex
    Amministratore
    34 Beauport Home Farm Close
    TN37 7BW St Leonards-On-Sea
    East Sussex
    United KingdomBritish7625370002
    SAMS, Ian James
    Fircroft Way
    TN8 6EZ Edenbridge
    C/O Eaton-Williams Group Limited
    Kent
    England
    Amministratore
    Fircroft Way
    TN8 6EZ Edenbridge
    C/O Eaton-Williams Group Limited
    Kent
    England
    EnglandBritish141142710002
    STAPLEY, Gerald Charles
    Huntersgay Stables Mill Lane Cottage
    Petworth Road Witley
    GU8 5LZ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Huntersgay Stables Mill Lane Cottage
    Petworth Road Witley
    GU8 5LZ Godalming
    Surrey
    EnglandBritish57940460001
    TRANTER, John
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish34350840002

    Chi sono le persone con controllo significativo di EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Eaton-Williams Group Limited
    Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    11th Floor, The Colmore Building
    England
    06 apr 2016
    Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    11th Floor, The Colmore Building
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a fircroft station road edenbridge fixed charge over all buildings and structures all goodwill and the proceeds of any claims of insurance all plant machinery and other chattels by way of floating charge all unnatached plant machinery and chattels and by way of assignment the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit b edenbridge industrial estate fircroft way edenbridge with all buildings and structures and any goodwill all plant machinery and other chattels the proceeds of any insurance claims by way of floating charge all unattached plant machginery chattels and goods and by way of lrgal assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a harleigh station road t/n KI73142 edenbridge and by way of fixed charge all goodwill,all plant machinery and other chattels and the proceeds of any insurance claim and by way of floating charge all unattached plant machinery and other chattels and by way of legal assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    "Wickham" station road TN8 6EE by way of fixed charge all buildings and structures,all goodwill,plant machinery and other chattels and the proceeds of any insurance claims and by way of floating charge all unattached plant machinery chattels and goods and by way of assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a factory site on the west side of station road edenbridge t/n K470263 fixed charges over all buildings,goodwill,plant machinery and other chattels the proceeds of any insurance claims and by way of floating charge all unnatached plant machinery and goods and by way of assignment the rental sums.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Under the terms of the guarantee the credit agreement or any of the other financing documents mortgage debenture
    Creato il 03 ago 1990
    Consegnato il 15 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee f/h property factory west side station road edenbridge t/no r 470 263 (plase seedoc 395/7 119/l/15/8 for full detaith)
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerceas Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries (As Detined)
    Transazioni
    • 15 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1984
    Consegnato il 06 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 27 feb 1984
    Consegnato il 03 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to be come due form the ealon-williams group limited investersto the on any account whietespever
    Brevi particolari
    Floaling charge over undertaking and allproperty and assets present and future iincluding bookdebts goodwill uncalled ca.
    Persone aventi diritto
    • Investers in Industry PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1984Registrazione di un'ipoteca

    EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 dic 2019Inizio della liquidazione
    19 nov 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Roderick Graham Butcher
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Praticante
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0