NEWMARKET FOODS LIMITED

NEWMARKET FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWMARKET FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00856471
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWMARKET FOODS LIMITED?

    • (0111) /
    • (0122) /

    Dove si trova NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Malton Bacon Factory Hugden Way
    Norton Grove Industrial Estate
    YO17 9HG Malton
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ISANDCO FPF REALISATIONS LIMITED07 nov 199607 nov 1996
    FAVOR PARKER FARMS LIMITED27 gen 198727 gen 1987
    FAVOR PARKER PIGS LIMITED17 ago 198417 ago 1984
    BAXTER PARKER LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    FAVOR PARKER LIVESTOCK LIMITED11 ago 196511 ago 1965

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al22 nov 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 apr 2011

    3 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Mawlaw Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Malton Bacon Factory Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Malton North Yorkshire YO17 9HG in data 06 gen 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 dic 2010

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 08 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2010

    Stato del capitale al 08 set 2010

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Cessazione della carica di Antonius Lammers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Louis Antoine Maria Vernaus come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Ronald William Francis il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Antonius Matheus Maria Lammers il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 22 nov 2008

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Segretario
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    British194640001
    TROLLOPE, Barry Desmond
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    British45609870001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ALLEN, Geoffrey Gordon
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    British15877490001
    COLES, Philip Charles John
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    Amministratore
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    British47148220001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    HOLMES, William Brian
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    British15877510001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Amministratore
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARKER, Benjamin James
    Gooderstone Manor
    Gooderstone
    PE33 9BP Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    Gooderstone Manor
    Gooderstone
    PE33 9BP Kings Lynn
    Norfolk
    British17414200001
    PARKER, John Gordon
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    British15877480001
    PARKER, Michael Joseph Bennett
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    British12897020001
    ROCHE, Nicholas James
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    Amministratore
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    EnglandBritish15836170001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001

    NEWMARKET FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An intercreditor and security agreement
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 08 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 24 ago 1987
    Consegnato il 01 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from favor parker limited under the terms of the charge to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Freehold property k/a the foulden estate, foulden, norfolk stock in trade, work in progress pre-payments investments (please see doc for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 01 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 24 ago 1987
    Consegnato il 26 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks shares other interests. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of agricultural property
    Creato il 24 ago 1987
    Consegnato il 26 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as or being foulden estate foulden norfolk together with certain rights more particularly described in and comprised in a conveyance dated 27/11/86.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 11 ott 1977
    Consegnato il 14 ott 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies advanced to favor parker livestock limited under an agreement dated 11TH october 1977 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by the debenture dated 11TH october 1977
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebets & uncalled capital. See doc M29.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 14 ott 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 ago 1974
    Consegnato il 11 set 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h including all fixtures, goodwill and uncalled capital present and future a floating charge.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank LTD
    Transazioni
    • 11 set 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NEWMARKET FOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 ago 2011Data di scioglimento
    15 dic 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0