TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00857447 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bank House 171 Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LUCKINS-TRADE SERVICE PUBLICATIONS LIMITED | 24 ago 1965 | 24 ago 1965 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 26 set 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di James Anthony Kirkland come segretario in data 07 nov 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di James Anthony Kirkland come amministratore in data 07 nov 2014 | 4 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di James Anthony Kirkland come segretario in data 07 nov 2014 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Mark Holland come segretario in data 07 nov 2014 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di John Ernest Huey Iii come amministratore in data 07 nov 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Steven Walter Berglund come amministratore in data 07 nov 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di James Anthony Kirkland come amministratore in data 07 nov 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di James Anthony Kirkland come segretario in data 07 nov 2014 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Anthony Harper come amministratore in data 07 nov 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRKLAND, James Anthony | Segretario | Stewart Drive 94085 Sunnyvale 935 California Usa | British | 193093670001 | ||||||
| BERGLUND, Steven Walter | Amministratore | Stewart Drive Sunnyvale 935 California 94085 Usa | United States | American | 183093300001 | |||||
| HUEY III, John Ernest | Amministratore | Stewart Drive Sunnyvale 935 California 94085 Usa | United States | American | 183093060001 | |||||
| KIRKLAND, James Anthony, Vice President | Amministratore | Stewart Drive 94085 Sunnyvale 935 California | United States | American | 183093010001 | |||||
| HARRIS, Andrew Philip | Segretario | 100 Aldrich Drive Willen MK15 9LU Milton Keynes Buckinhgamshire | British | 117394820001 | ||||||
| HOLLAND, Timothy Mark | Segretario | Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes Bank House 171 | 169884430001 | |||||||
| HOPKINS, Douglas Alan | Segretario | 39 Kesteven Road PE9 1SX Stamford Lincolnshire | British | 5541650001 | ||||||
| JACKSON, Russell Henry | Segretario | 178 Stonald Road Whittlesey PE7 1QR Peterborough Cambridgeshire | British | 47029040001 | ||||||
| KIRKLAND, James Anthony | Segretario | Stewart Drive Sunnyvale 935 California 94085 Usa | British | 195583230001 | ||||||
| BULLARD, Michael | Amministratore | 62 Tinwell Road PE9 2SD Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 5541660001 | |||||
| BULLARD, Paul | Amministratore | 6 Crocket Lane Empingham LE15 8PW Oakham Leicestershire | British | 5541670001 | ||||||
| GREENWOOD, Andrew Keith | Amministratore | Woodyard Cottage Bottom Street Witham On The Hill PE10 0JP Bourne Lincolnshire | British | 49353180001 | ||||||
| GREENWOOD, Andrew Keith | Amministratore | Woodyard Cottage Bottom Street Witham On The Hill PE10 0JP Bourne Lincolnshire | British | 49353180001 | ||||||
| HARPER, Nicholas Anthony | Amministratore | Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes Bank House 171 | England | British | 169818890001 | |||||
| HARRIS, Andrew Philip | Amministratore | 100 Aldrich Drive Willen MK15 9LU Milton Keynes Buckinhgamshire | United Kingdom | British | 117394820001 | |||||
| HOLLAND, Timothy Mark | Amministratore | Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes Bank House 171 | United Kingdom | British | 221315490001 | |||||
| HOLLAND, Timothy Mark | Amministratore | Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes Bank House 171 | United Kingdom | British | 221315490001 | |||||
| JACKSON, Russell Henry | Amministratore | 178 Stonald Road Whittlesey PE7 1QR Peterborough Cambridgeshire | British | 47029040001 | ||||||
| LUCKINS, Andrew Roger | Amministratore | 20 Park Lane SG3 6PH Knebworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 1563080001 | |||||
| PYLE, Charles Joseph | Amministratore | 393 San Gorgonio Street San Diego California 92106 Usa | Usa | United States | 71448120001 | |||||
| SIMPSON, James Alan | Amministratore | PO BOX 2608 Rancho Santa Fe California Usa | American | 33839700001 | ||||||
| TINDALL, Mark | Amministratore | Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes Bank House 171 | Uk | British | 134448640002 | |||||
| WARD, Andrew | Amministratore | The Old Waterworks Gretton Road, Lyddington, Oakham LE15 9HN Rutland | British | 91655640002 | ||||||
| WARD, Donna Jacqueline | Amministratore | The Old Water Works Gretton Road LE15 9HN Lyddington Rutland | United Kingdom | British | 63020580005 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsi Stamford Limited | 06 apr 2016 | 171 Midsummer Boulevard MK9 1EB Central Milton Keynes Bank House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TRADE SERVICE INFORMATION LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Creato il 01 mar 2010 Consegnato il 05 mar 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All rights title and interest from time to time in each of the intellectual property and the related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 mar 2010 Consegnato il 05 mar 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 ott 2008 Consegnato il 05 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 04 ott 1976 Consegnato il 13 ott 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as brownlow street & cherry holt road, stamford, lincs. Conveyance dated 27/7/74. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0