WENGAIN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWENGAIN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00861630
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WENGAIN LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WENGAIN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O LEATHERS LLP
    17th Floor
    Cale Cross House Pilgrim Street
    NE1 6SU Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WENGAIN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GEORGE HALL (SALES) LIMITED15 ott 196515 ott 1965

    Quali sono gli ultimi bilanci di WENGAIN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per WENGAIN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2013

    Stato del capitale al 23 gen 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Leathers Llp 17th Floor Cale Cross House Pilgrim Street Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE1 6SU in data 17 feb 2011

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Amber Isobel Mary Dane il 31 dic 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di WENGAIN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEATHER, Michael Robert
    New House
    Newhouse Road
    DH7 9LQ Esh Winning
    County Durham
    Segretario
    New House
    Newhouse Road
    DH7 9LQ Esh Winning
    County Durham
    British112734960001
    DANE, Amber Isobel Mary
    Forge House
    Hever
    TN8 7NH Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Forge House
    Hever
    TN8 7NH Edenbridge
    Kent
    EnglandBritishNone125459130001
    BACK, Maurice Walter
    66 Crescent Road
    CM12 0HU Billericay
    Essex
    Segretario
    66 Crescent Road
    CM12 0HU Billericay
    Essex
    British7262320001
    LEATHER, Michael Robert
    New House
    Newhouse Road
    DH7 9LQ Esh Winning
    County Durham
    Segretario
    New House
    Newhouse Road
    DH7 9LQ Esh Winning
    County Durham
    British112734960001
    MCGRATH, Fintan
    Tanglewood, Roughpark,
    Ballykaleen
    IRISH Letterkenny
    County Donegal
    Ireland
    Segretario
    Tanglewood, Roughpark,
    Ballykaleen
    IRISH Letterkenny
    County Donegal
    Ireland
    British108104910001
    PEACH, Karl
    28 Wyvern Road
    B74 2PT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    28 Wyvern Road
    B74 2PT Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishFinance Director40592670003
    PEARSON, John Anthony
    44 Maple Avenue
    RM14 2LE Upminster
    Essex
    Segretario
    44 Maple Avenue
    RM14 2LE Upminster
    Essex
    British29480790002
    QUINN, Frank
    4 Berber Road
    SW11 6RZ London
    Segretario
    4 Berber Road
    SW11 6RZ London
    British60264060001
    WHITECHURCH, Peter James
    1 Dale Cottages
    Tangier Lane Frant
    TN3 9HE Tunbridge Wells
    East Sussex
    Segretario
    1 Dale Cottages
    Tangier Lane Frant
    TN3 9HE Tunbridge Wells
    East Sussex
    British41218800001
    OSBORNE SECRETARIES LIMITED
    The Cube
    Barrack Road
    NE4 6DB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    The Cube
    Barrack Road
    NE4 6DB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    96177820001
    DANE, Amber Isobel Mary
    Chippens Bank House
    Station Road
    TN8 7ES Hever
    Kent
    Amministratore
    Chippens Bank House
    Station Road
    TN8 7ES Hever
    Kent
    United KingdomBritishDental Hygenist3363640002
    DANE, Christopher Donald
    Chippens Bank House
    Station Road
    TN8 7ES Hever
    Kent
    Amministratore
    Chippens Bank House
    Station Road
    TN8 7ES Hever
    Kent
    BritishCompany Director34107220001
    DANE, Patrick Donald
    Forge House
    Hever
    TN8 7NH Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Forge House
    Hever
    TN8 7NH Edenbridge
    Kent
    BritishChairman96083660002
    LEATHER, Michael Robert
    New House
    Newhouse Road
    DH7 9LQ Esh Winning
    County Durham
    Amministratore
    New House
    Newhouse Road
    DH7 9LQ Esh Winning
    County Durham
    United KingdomBritishAccountant112734960001
    MANNING, David Brown
    Home Farm
    Hanley Swan
    WR8 0EF Worcester
    Amministratore
    Home Farm
    Hanley Swan
    WR8 0EF Worcester
    United KingdomBritishCompany Director118638810002
    RICH, Deborah Mary
    2 Brickyard Cottages
    Redwall Lane, Hunton
    ME15 0RJ Maidstone
    Kent
    Amministratore
    2 Brickyard Cottages
    Redwall Lane, Hunton
    ME15 0RJ Maidstone
    Kent
    BritishChemical Trading70009450001

    WENGAIN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory charge
    Creato il 27 giu 1991
    Consegnato il 04 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 24 may 1990
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the south west side of alexandra park fishponds bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creato il 27 giu 1991
    Consegnato il 04 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 24 may 1990
    Brevi particolari
    F/H property k/a 40 hutton close crowther washington tyne and wear. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creato il 27 giu 1991
    Consegnato il 04 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 10 july 1990
    Brevi particolari
    L/H property k/a land fronting chestergate and hardman street stockport greater manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creato il 27 giu 1991
    Consegnato il 04 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 8 july 1988.
    Brevi particolari
    F/H property k/a 83 & 84 warwick street, deritend birmingham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 lug 1990
    Consegnato il 23 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land fronting chestergate & hardman street stockport greater manchester title no gm 524382 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 mag 1990
    Consegnato il 04 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the south west side of alexandra park fishponds bristol avon title no av 5229 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 mag 1990
    Consegnato il 04 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    40 hutton close crowther washington tyne & wear t/n ty 225443 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 08 lug 1988
    Consegnato il 20 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    83 & 84 warwick street deritend birmingham west midlands title no. Wm 29354 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0