BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED

BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00865032
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLETCHLEY MOTORS (RENTALS) LIMITED26 nov 196526 nov 1965

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Stato del capitale al 23 feb 2021

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Notifica di Bletchley Motor Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    221615060001
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector229010610001
    BAYER, John Leslie
    Cranfield Road
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Cranfield Road
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British10636350002
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    BritishFinance Director65759080001
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector21483450001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector41559790001
    BAYER, John Leslie
    Millclair Mill Road
    Whitfield
    NN13 5TQ Brackley
    Northants
    Amministratore
    Millclair Mill Road
    Whitfield
    NN13 5TQ Brackley
    Northants
    BritishCompany Director10741750001
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Amministratore
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritishDirector29331220001
    BROWN, Philip David
    Cranfield House
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cranfield House
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCar Rental Manager54856770002
    DUNN, David John
    Tyrells Manor
    Stoke Hammond
    MK17 9BX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tyrells Manor
    Stoke Hammond
    MK17 9BX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCar Sales Manager69330910002
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    BritishFinance Director65759080001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector21483450001
    JONES, Anthony Brian
    Cranfield House
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cranfield House
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishVehicle Rental Manager10778560003
    MATHER, Colin
    60 Wilford Avenue
    NN3 9UQ Northampton
    Amministratore
    60 Wilford Avenue
    NN3 9UQ Northampton
    BritishOperations Manager54458550001
    RIDGE, Stuart Jonathon
    Cranfield House
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cranfield House
    Wavendon
    MK17 8LQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishAccountant10778570002
    SNARR, Peter David
    22 Carnoustie Drive
    Tytherington
    SK10 2TB Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    22 Carnoustie Drive
    Tytherington
    SK10 2TB Macclesfield
    Cheshire
    BritishVehicle Leasing Management30021640002
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bletchley Motor Group Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione1650846
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BLETCHLEY MOTOR RENTALS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 mag 1998
    Consegnato il 01 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as therein defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 05 lug 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Forward Motor Finance Limited Acting as Principal or as Agent of Any Other Company Orcompanies (As Defined)
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 31 dic 1986
    Consegnato il 31 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 mag 1983
    Consegnato il 11 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All books debts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 feb 1982
    Consegnato il 16 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1) by way of fixed charge all leasing contract hire and similar agreements as set out in the schedule numbered 5 attached thereto and any subsequent leasing contract hire and written agree ments entered into by the company which have been so franked by british credit trust limited. 2) by way of floating charge, all leasing contact hire and similar agreements, entered into by the company as owner or bailor with third parties on merchandise loaned by british credit trust LTD to the company upon the standard hire purchase terms and conditions of british credit trust limited.
    Persone aventi diritto
    • British Credit Trust Limited
    Transazioni
    • 16 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 19 mar 1981
    Consegnato il 03 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge on all leasing contract hire & similar agreements entered into by the company with third parties for letting & hire of motor vehicles. (See doc M35).
    Persone aventi diritto
    • British Credit Trust Limited
    Transazioni
    • 03 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Master agreement & charge
    Creato il 31 ott 1979
    Consegnato il 02 nov 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Master agreement & charge over each sub-hiring agreement & the rights & choses in action both present & future created thereby in favour of the company & each maintenance agreement (if any) & the benefit of all securities & guarantees (if any) for the same & includes any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited.
    Transazioni
    • 02 nov 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 04 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 ott 1979
    Consegnato il 06 nov 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0