TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00868498 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
- Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio
- Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| APPLIED DISTRIBUTION LIMITED | 03 mar 1989 | 03 mar 1989 |
| GEEST DISTRIBUTION LIMITED | 02 set 1988 | 02 set 1988 |
| GROUND'S TRANSPORT (BOSTON) LIMITED | 10 gen 1966 | 10 gen 1966 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jane Li come segretario in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Steven Fink come amministratore in data 26 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione di Jane Li come persona con controllo significativo il 26 nov 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||
Notifica di Exel Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione della carica di Jane Li come amministratore in data 26 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di James Edward Gill come amministratore in data 13 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione di James Edward Gill come persona con controllo significativo il 13 giu 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||
Nomina di Thorsten Kuhl come amministratore in data 13 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2016 | 13 pagine | AA | ||
legacy | 192 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr James Edward Gill come amministratore in data 01 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Keith Roy Smith come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Michael James Trimm come amministratore in data 09 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINK, Steven | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 158324340001 | |||||||||
| KUHL, Thorsten | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Germany | German | 247678730001 | |||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Segretario | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 64948610002 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Segretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Segretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| GRAY, Roderick James | Segretario | 5 Gresham Close RH8 0BH Oxted Surrey | British | 10767150002 | ||||||||||
| LI, Jane | Segretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 203503560001 | |||||||||||
| MILLS, John Michael | Segretario | 103 Moffats Lane AL9 7RP Brookmans Park Hertfordshire | British | 193353200001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Segretario | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | British | 45625440002 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Segretario | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | British | 15165070001 | ||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Amministratore | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 64948610002 | |||||||||
| AUSTIN, Keith James | Amministratore | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 69617780001 | |||||||||
| BRABENDER, Murray Robert Malcolm | Amministratore | 19 Phoenix Drive Wateringbury ME18 5DR Maidstone Kent | British | 50169470001 | ||||||||||
| BROWN, David | Amministratore | Dunvegan Devonburn ML11 9PU Lesmahagow Lanarkshire | British | 15524300001 | ||||||||||
| BUMSTEAD, Jonathan Culver | Amministratore | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 72820970001 | |||||||||
| BUTT, Kenneth Thomas John | Amministratore | Hatchfield House Epsom Road, West Horsley KT24 6DX Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 80963930001 | |||||||||
| CAMERON, Ian, Mr. | Amministratore | 66 High Street Stagsden MK43 8SQ Bedford Gamekeepers Cottage England | England | British | 164576100001 | |||||||||
| COOKE, Gordon Leslie | Amministratore | 92 High Street Wrestlingworth SG19 2EJ Sandy Bedfordshire | British | 34718600001 | ||||||||||
| DAVIS, Leonard John | Amministratore | 25 Hathaway Court ME1 1QX Rochester Kent | British | 15524310001 | ||||||||||
| ELLIS, Michael John | Amministratore | Little Trodgers Honor End Lane, Prestwood HP16 9HG Buckinghamshire | England | British | 133791220001 | |||||||||
| FERGUSON, Peter | Amministratore | 39 Pickering Street Loose ME15 9RS Maidstone Kent | British | 15524290001 | ||||||||||
| GILL, James Edward | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 165998750001 | |||||||||
| GRAY, Roderick James | Amministratore | 5 Gresham Close RH8 0BH Oxted Surrey | British | 10767150002 | ||||||||||
| HEAL, Stephen Alan | Amministratore | The Paddocks Drove Road Gamlingay SG19 3NY Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | 42087770001 | |||||||||
| HOWES, David William | Amministratore | Old Walls Birdingbury Road, Leamington Hasting CV23 8EB Rugby Warwickshire | British | 53711750001 | ||||||||||
| LI, Jane | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 134292740003 | |||||||||
| MANN, Roger Michael Ewart | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 15476780001 | |||||||||
| MATHIAS, Alfred Robert | Amministratore | Trillick Furzedown Lane Amport SP11 8BW Andover Hampshire | British | 9433680001 | ||||||||||
| PALMER, Martin Robert | Amministratore | 9 Maple Road OX9 2BH Thame Oxfordshire | British | 45138540001 | ||||||||||
| ROWLEY, Michael James | Amministratore | 6 The Depository Rock Villa Road TN1 1HA Tunbridge Wells Kent | England | British | 10767160002 | |||||||||
| SEY, Kevin Paul | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 186787040001 | |||||||||
| SMITH, Jamie Robert Mark | Amministratore | Tanglewood 33 Woodend Drive SL5 9BD Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | 74084830002 | |||||||||
| SMITH, Keith Roy | Amministratore | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 140889200001 | |||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Amministratore | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | England | British | 15165070001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Jane Li | 01 giu 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr James Edward Gill | 01 giu 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Exel Holdings Limited | 06 apr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Creato il 26 apr 1996 Consegnato il 01 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 23RD february 1996 numbered 47.170.19.111372 and this assignment | |
Brevi particolari All monies due under the "assigned agreements" (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 giu 1994 Consegnato il 12 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 mar 1989 Consegnato il 14 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14/2/89 and a debenture dated 14/2/89 | |
Brevi particolari First fixed charge over all and whole a lease on the north side of old edinburgh road bellshill larnarkshire title no: lan 1159. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 feb 1989 Consegnato il 20 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14.2.89 | |
Brevi particolari (See doc. For full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0