CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00872374
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED?

    • Banche (64191) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al24 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 set 2015

    4 pagine4.68

    Cessazione della carica di Bernadette Allinson come segretario in data 15 giu 2015

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 12 apr 2015

    2 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Indirizzo della sede legale modificato da 16 Palace Street London SW1E 5JQ a 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 09 ott 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 set 2014

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2014

    Stato del capitale al 07 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,512,433.6
    SH01

    Nomina di Mr. Ganesh Raj Jayaraman come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Flemming Dalgaard come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 24 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 24 dic 2011

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarmad Mehmood Qureshi il 27 gen 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 24 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarmad Mehmood Qureshi il 03 mar 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Arthur Walker il 29 set 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 24 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAYARAMAN, Ganesh Raj, Mr.
    Buckingham Gate
    SW1E 6BS London
    51
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6BS London
    51
    United Kingdom
    United KingdomAustralian184531160001
    QURESHI, Sarmad Mehmood
    Central Way
    Carshalton Beeches
    SM5 3NF Surrey
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Central Way
    Carshalton Beeches
    SM5 3NF Surrey
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish159707370002
    WALKER, Peter Arthur
    Woodman Lane
    Sewardstonebury
    E4 7QR London
    Montrose
    United Kingdom
    Amministratore
    Woodman Lane
    Sewardstonebury
    E4 7QR London
    Montrose
    United Kingdom
    United KingdomBritish708770002
    ALLINSON, Bernadette
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Segretario
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Other116264270002
    ALLINSON, Bernadette
    Linden Lea
    Hutton Roof
    LA6 2PG Kirkby Lonsdale
    Lancashire
    Segretario
    Linden Lea
    Hutton Roof
    LA6 2PG Kirkby Lonsdale
    Lancashire
    Other116264270001
    ASHURST, John Richard
    20 Culverhay
    KT21 1PR Ashtead
    Surrey
    Segretario
    20 Culverhay
    KT21 1PR Ashtead
    Surrey
    British31732150003
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Segretario
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    British11498530001
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Segretario
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    British11498530001
    NICHOLSON, David John
    PO BOX 3627
    Dubal Sheikh Zayed Road
    Dubai
    United Arab Emirates
    Segretario
    PO BOX 3627
    Dubal Sheikh Zayed Road
    Dubai
    United Arab Emirates
    Australian72637800002
    WYATT, Edmund Kenneth
    145 Oaklands Avenue
    Oxhey
    WD1 4LH Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    145 Oaklands Avenue
    Oxhey
    WD1 4LH Watford
    Hertfordshire
    British10691680001
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Amministratore
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    United KingdomBritish11498530001
    DALGAARD, Flemming
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomDanish116091010001
    EDGERLEY, William Thomas
    1 Diamond Terrace
    Greenwich
    SE10 8QN London
    Amministratore
    1 Diamond Terrace
    Greenwich
    SE10 8QN London
    EnglandBritish36091100002
    FERGUSON, Robert George
    The Warren 51 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    Amministratore
    The Warren 51 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    British10691690002
    FLETCHER, Angus Howard
    9 Lees Heights
    Charlbury
    OX7 3EZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    9 Lees Heights
    Charlbury
    OX7 3EZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish65254010001
    HARDING, Timothy John Randolph
    7 Paradise Walk
    SW3 3LJ London
    Amministratore
    7 Paradise Walk
    SW3 3LJ London
    British36607720002
    KNIGHT, Raymond Antony
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    British2198910001
    PREISKEL, Anthony Alexander
    93 Corringham Road
    NW11 7DL London
    Amministratore
    93 Corringham Road
    NW11 7DL London
    United KingdomBritish36551930001
    SADLER, Christopher Frank
    59a Marney Road
    Battersea
    SW11 5EW London
    Amministratore
    59a Marney Road
    Battersea
    SW11 5EW London
    British36608160001
    WINHAM, Basil Arthur
    Flat 7 22 Eaton Square
    SW1W 9DE London
    Amministratore
    Flat 7 22 Eaton Square
    SW1W 9DE London
    British96570410001
    WOOLLACOTT, John Mark
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Amministratore
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Australian121666370002

    CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental trust deed
    Creato il 23 dic 1992
    Consegnato il 13 gen 1993
    In corso
    Importo garantito
    £2,455,000 representing 7.5% per annum first mortgage debenture stock 1997/2002 constituted and secured by a trust deed dated 19/10/67 and 25 supplemental trust deeds
    Brevi particolari
    Headleasehold property k/a provincial house 31/45 new walk leicester t/n LT54459 underlease property k/a provincial house aforesaid t/n LT54549.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 13 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental trust deed
    Creato il 21 dic 1989
    Consegnato il 10 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,110,081 7 1/4% first mortgage debenture stock 1991/96 of p&o property holdings limited and other monies secured by a trust deed dated 22.10.65 and made between town & city properties limited and others and the norwich life insurance society and various deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    840-846 (even) osmaston road, allerton, derby t/nos. DY118378 & DY117163, 37-43 regent street and 2A downend road, kingswood, avon t/nos. AV90207 & AV89910, 404-430 (even) high street west bromwich t/nos. WM390485 & WM52525.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 10 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 1991Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge deed.
    Creato il 07 dic 1988
    Consegnato il 13 dic 1988
    In corso
    Importo garantito
    For further securing the principle and interest on £5,587,800. first mortgage debenture stock 2000 of p&o property holdings limited and other monies intended to be secured by a trust deed dated 24-12-1985.
    Brevi particolari
    Freehold property k/a:- 45-49 and 53-57 birmingham road, sutton coldfield. Together with all buildings erections fixed plant & machinery and landlords fixtures thereon and all rights powers easements and appurtenances thereto belonging.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society.
    Transazioni
    • 13 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Supplemental trust deed
    Creato il 22 nov 1988
    Consegnato il 29 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing the principal of and interest on all the outstanding £4,500,000 8 3/4% first-mortgage debenture stock 1995/98 of the company and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of a supplemental trust deed dated 25/3/68 and various other deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the property specified below together with all buildings and erections and all fixed plant, fixed machinery and all fixtures. F/h & l/h property the wells green shopping precinct 2146-2170 (even numbers only). Coventry road, sheldon birmingham t/nos. Wk 82719; wk 123554.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 29 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed.
    Creato il 29 lug 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,750,000 1ST mortgage debenture stock 1997 due from town and city properties limited now k/as p & o property holdings limited to the charges and any other moneys intended to be secured under the terms of the trust deed dated 24.12.85. and the charge.
    Brevi particolari
    Cash deposit of £320,000.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widow's Fund and Life Assurance Society.
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed.
    Creato il 09 dic 1987
    Consegnato il 11 dic 1987
    In corso
    Importo garantito
    For further securing £4,500,000 8 3/4% first mortgage debenture stock 1995/98 of the company and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 25/3/68 and other deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/H the wells green shopping precinct 2146-2170 (even nos) coventry road sheldon birmingham t/n wk 82719 l/h the wells green shopping precinct 2146-2170 (even nos) coventry road sheldon birmingham wk 123554.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance.
    Transazioni
    • 11 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed
    Creato il 21 mag 1987
    Consegnato il 05 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all the outstanding £4,500,000 8 3/4% fixed mortgage debenture stock 1995/98 of the company and all other moneys intended to be secured by the charge and trust deed and other deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    1 freehold property k/a city house friar lane nottingham title no. Nt 166724 together with all buildings and erections and all fixed plant fixed machinery and all fixture (including trade, fixtures) 2. leasehold property k/a city house, friar lane nottingham title no. Nt 113587 together with all buildings and erections and all fixed plant fixed machinery and all fixtures (including trade fixtures) therein.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 05 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 24 mar 1987
    Consegnato il 30 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from town & city properties limited to the chargee. Pursuant to a supplemental trust deed dated 24/12/85 and all other moneys therein secured
    Brevi particolari
    A cash deposit of £245,692 with the society together with interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transazioni
    • 30 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed
    Creato il 19 dic 1986
    Consegnato il 24 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from town & city properties limited pursuant to a supplemental trust deed dated 24 december 1985 and all other monies secured by the principal deed.
    Brevi particolari
    A cash deposit of £450,000 with the society. Together with interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society.
    Transazioni
    • 24 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed
    Creato il 17 dic 1986
    Consegnato il 31 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,455,000 71/2 % first mortgage stock (1997-2002) of town city properties limited and all other moneys intended to be secured by the said supplemental trust deed a trust deed dated 19 oct 1967 and various deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/Hold & l/hold property k/as parham house 404-430 (even no's) high street, west bromwich west midlands (f/hold title no. Wm 390485 l/hold title no. Wm 52525) together with all buildings erections and all fixed plant machinery and landlands fixtures etc.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 31 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental deed of charge
    Creato il 17 mar 1986
    Consegnato il 05 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to and under the terms of the principal deeds
    Brevi particolari
    Onslow house, 5 to 11 onslow street camden.
    Persone aventi diritto
    • Royal Lever Trustees Limited.
    Transazioni
    • 05 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed registered pursuant to an order of court.
    Creato il 24 dic 1985
    Consegnato il 13 ago 1986
    In corso
    Importo garantito
    £5,587,800 first mortgage debenture stock 2000 of town & city properties limited and all other moneys intended to be secured by the trust deed.
    Brevi particolari
    L/Hold healey road scunthorpe. Title no. Hs 14743 and lease dated 25 nov. 1973 together with all buildings and erections and fixed plant and machinery and landlord's fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widow's Fund and Life Assurance Society
    Transazioni
    • 13 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 24 dic 1985
    Consegnato il 10 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,750,000 first mortgage debenture stock 1997 of town & city properties limited & all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 25 nov 1977 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    F/H 1-10 summer's street finsbury, london EC1 title no. Ngl 137373 f/h gaytoy works, foxton road, south stifford grays essex. F/h 45-49 and 53-57 birmingham road, sutton coldfield, birmingham title nos. Wk 143453 and wm 175106 together with all buildings & erections & fixed plant & machinery & land lord's fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transazioni
    • 10 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed
    Creato il 17 dic 1985
    Consegnato il 24 dic 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for securing £4,500,000 8 3/4% first mortgage debenture stock 1995/98 secured by a trust deed dated 25/3/68 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Land situated in and having a frontage to coronation road, cressex industrial estate high wycombe buckingham & factory premises & other buildings erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 24 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Deed of release and substitution
    Creato il 08 giu 1985
    Consegnato il 02 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,000,000 8 1/2% first mortgage debenture stock of the arndale property trust limited and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 31ST august 1965 as varied by deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Debenture stock of the arndale property trust limited together with the interest payable thereon and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 31 august 1965 between the arndale property trust limited an dcommercial union assurance company PLC. As varied by deeds supplemental to the trust deed dated 31ST august 1965. for full details see form m 148.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Union Assurance Company PLC.
    Transazioni
    • 02 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 20 mar 1985
    Consegnato il 04 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £3,000,000 7 1/4% first mortgage debenture stock 1991/96 of town & city properties limited & all moneys intended to be secured by a trust deed dated 22/10/65 & deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/H & l/h premises at 93-97 (odd numbers) whiteladies road clifton briston title nos: av 90224 & av 89056 together with all cladys etc (see doc M145).
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society.
    Transazioni
    • 04 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed.
    Creato il 20 mar 1985
    Consegnato il 25 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a trust deed dated 19.10.1967 and 17 deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    (1) 840-846 osmanton road derby. F/h title dy 118378 l/h title dy 117163 (2) 37, 39 41 & 43 regent street and 2A downend road kingswood bristol f/h t/n av 9207 l/h av 899109 (3) 13/14 woking street cardiff f/h wa 275255 l/h tn wa 272198 together with all buildings & erections, all fixed plant machinery & landlords fixtures etc.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society.
    Transazioni
    • 25 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 10 ott 1984
    Consegnato il 16 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from sterling guarantee trust PLC to the chargee
    Brevi particolari
    L/H halifax house, coronation road, cressex industrial estate, high wycombe, buckinghamshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 10 ott 1984
    Consegnato il 16 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from sterling guarantee trust PLC to the chargee
    Brevi particolari
    L/H the arndale centre, bolton road, walkden, greater manchester t/n gm 220203. and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 10 ott 1984
    Consegnato il 16 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from sterling guarantee trust plfc to the chargee
    Brevi particolari
    L/H the arndale centre, bolton road, walkeden greater manchester. T/n gm 262426.and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 10 ott 1984
    Consegnato il 10 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from sterling guarantee trust PLC to the chargee
    Brevi particolari
    L/H miller arcade, chruch street, preston, lancashire t/n la 386100 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1984
    Consegnato il 23 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or sterling guarantee trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H 13 13A & 14 middlegate penrith aimbria.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1984
    Consegnato il 23 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or sterling guarantee trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H land & buildings formerly the site of osborne hotel & 26 & 28 bailey street onwestry, shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1984
    Consegnato il 23 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or sterling guarantee trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H 30 & 30A high street, bogaed, mid-glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1984
    Consegnato il 23 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or sterling guarantee trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H land and buildings formerly the site of 50/56 (evens) high street alfreton derby, derbyshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1984Registrazione di un'ipoteca

    CHARLWOOD ALLIANCE HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ago 2016Data di scioglimento
    19 set 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0