GEOFFREY OSBORNE LIMITED

GEOFFREY OSBORNE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGEOFFREY OSBORNE LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00873093
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
    • Costruzione di strade e autostrade (42110) / Costruzioni
    • Altre installazioni in costruzioni (43290) / Costruzioni

    Dove si trova GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 dic 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 dic 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 dic 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Cessazione della carica di Peter Edward Duff come amministratore in data 01 set 2024

    1 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    63 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    29 pagineAM02

    Cessazione della carica di David Gordon Smith come amministratore in data 31 mag 2024

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Fonteyn House 47-49 London Road Reigate Surrey RH2 9PY a C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB in data 10 mag 2024

    3 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Soddisfazione dell'onere 008730930024 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 008730930024, creata il 22 set 2023

    52 pagineMR01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2022 al 31 mar 2023

    1 pagineAA01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 008730930023

    1 pagineMR05

    Cessazione della carica di John Fernandez come segretario in data 10 mar 2023

    1 pagineTM02

    Iscrizione dell'ipoteca 008730930023, creata il 03 mar 2023

    57 pagineMR01

    Cessazione della carica di Mark David Taylor come amministratore in data 21 feb 2023

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 008730930022 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Sarah Catherine Taylor come amministratore in data 09 dic 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard Martyn King come amministratore in data 11 ott 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter Edward Duff come amministratore in data 20 set 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Hammond come amministratore in data 19 set 2022

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OSBORNE, Andrew Simon Charles
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish69198210019
    BURDEN, Franklyn David
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    Segretario
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    British4360750001
    FERNANDEZ, John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Segretario
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    293995010001
    HAMMOND, Stuart
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    British179087810001
    HATTON, Thomas David Michael
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    Segretario
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    British728380004
    OSBORNE, Andrew Simon Charles
    Osborne House
    51 Fishbourne Road East
    PO19 8LL Chichester
    C/O Geoffrey Osborne Limited
    West Sussex
    Segretario
    Osborne House
    51 Fishbourne Road East
    PO19 8LL Chichester
    C/O Geoffrey Osborne Limited
    West Sussex
    British69198210013
    BALDWIN, Richard Keith, Dr
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Amministratore
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    United KingdomBritish37207590001
    BURDEN, Franklyn David
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    British4360750001
    CHADWICK, John Rennie, Dr
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    EnglandBritish136362410001
    CLAYTON, Marie-Louise Louise
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish163090500001
    COWAN, Ralph
    Grinton 5 Aldenham Grove
    WD7 7BW Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Grinton 5 Aldenham Grove
    WD7 7BW Radlett
    Hertfordshire
    British670630002
    CRAIG, John David, Mr.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    EnglandBritish215898750001
    DAINES, Graham
    24 Hunters Mews
    Fontwell
    BN18 0UW Arundel
    West Sussex
    Amministratore
    24 Hunters Mews
    Fontwell
    BN18 0UW Arundel
    West Sussex
    British4400050002
    DOWSETT, John Vincent
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish215898790001
    DUFF, Peter Edward
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish89262050002
    EVERARD, Brian Kenneth
    5 Old Place
    Aldwick
    PO21 3AU Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    5 Old Place
    Aldwick
    PO21 3AU Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritish17789250001
    FISON, David Gareth
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish60231310001
    HAMMOND, Stuart
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish154194990001
    HEASMAN, Mark
    Mill House
    Bulford Mill Lane Cressing
    CM77 8NT Braintree
    Essex
    Amministratore
    Mill House
    Bulford Mill Lane Cressing
    CM77 8NT Braintree
    Essex
    EnglandBritish115901610001
    HOOPER, David Matthew William
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    UkBritish168207200001
    KELLEY, Anthony John
    Broadlands
    27 Ralliwood Road
    KT21 1DD Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Broadlands
    27 Ralliwood Road
    KT21 1DD Ashtead
    Surrey
    British34076900001
    KING, Richard Martyn
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish154195030001
    LIDDLE, Stephen
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Amministratore
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    EnglandBritish105835710001
    MATTHEWS, Timothy John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish50382860001
    MURRAY, Simon Anthony
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Amministratore
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    EnglandBritish79856110001
    OLIVER, John Frank
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Amministratore
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    EnglandBritish17813980001
    OSBORNE, Geoffrey Clement Howard
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    British4360760001
    OSBORNE, Pamela Agnew
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    Great BritainBritish4360770001
    PETTER, Michael John
    4 Romyns Court
    PO14 1NB Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    4 Romyns Court
    PO14 1NB Fareham
    Hampshire
    EnglandBritish69338760002
    SHEPHERD, Gordon Bruce
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish78724260001
    SHORTMAN, Philip John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish190035630001
    SMITH, David Gordon, Mr.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish78869630003
    STEELE, Andrew Philip
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish179702030022
    STERLING, Nicholas John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish97129450001
    TAYLOR, Mark David
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Amministratore
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    EnglandBritish117602770001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GEOFFREY OSBORNE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    31 gen 2018
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11056197
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07543585
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GEOFFREY OSBORNE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 set 2023
    Consegnato il 27 set 2023
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • B.I.G Finance Limited
    Transazioni
    • 27 set 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 apr 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 mar 2023
    Consegnato il 08 mar 2023
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Osborne Group Holdings LTD
    Transazioni
    • 08 mar 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 apr 2023Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2019
    Consegnato il 23 dic 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as wickfield house, 18-22 disney place, london, SE1 1HJ registered at hm land registry under title number LN26705.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cynergy Bank Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 feb 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2019
    Consegnato il 16 mag 2019
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 giu 2015
    Consegnato il 23 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 mag 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 giu 2015
    Consegnato il 03 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Gcho (Security Trustee) Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2013
    Consegnato il 16 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H land k/a wickfield house 18-22 disney place london t/no LN26705. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Gcho (Security Trustee) Limited
    Transazioni
    • 16 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over security account
    Creato il 08 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The account balance from time to time of the security account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its present and future rights, title and interest in and to (a) the security account; and (b) the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caring 4 Croydon Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge on deposit
    Creato il 17 dic 2003
    Consegnato il 18 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being all monies on the account and all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on deposit
    Creato il 10 ott 2001
    Consegnato il 11 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000.00 and all other sums due from the company to the chargee under the facility agreement and/or this charge on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit of £225,000.00 and all entitlements to interest and other rights,benefits thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 11 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 2000
    Consegnato il 01 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    18/22 disney place london SE1.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 01 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment
    Creato il 21 mag 1998
    Consegnato il 29 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys due or owing to the company under or by virtue of the contract dated 19/12/97. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 06 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from geoffrey osborne investments limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule to form 395 please see form for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 09 ago 1993
    Consegnato il 17 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from geoffrey osborne (developments) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Higher interest account no. 70123838. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 28 mar 1993
    Consegnato il 14 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re geoffrey osborne limited gts bid deposit bid no 90133205. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1987
    Consegnato il 29 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at manor farm lavant chichester west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1987
    Consegnato il 29 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining stockbridge house, stockbridge road, chichester west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creato il 21 ago 1987
    Consegnato il 04 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Little meadow and gevelia cottage, smoch alley west chiltington west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1987
    Consegnato il 29 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at ham manor golf club, west-sussex title no sx 55065.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 1983
    Consegnato il 19 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold wessex gate, formerly known as 23, portsmouth rd., Hamdean, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1983
    Consegnato il 25 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold osborne house stockbridge road. Chichester west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 mag 1982
    Consegnato il 07 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £101,140 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Land and buildings comprised in title no. Sy 506869 forming part of nonsuch industrial estate.
    Persone aventi diritto
    • Tanley Bridge Limited
    Transazioni
    • 07 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 gen 1982
    Consegnato il 26 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises at quarry lane, chichester, west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 mar 1979
    Consegnato il 30 mar 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at quarry lane chichester, west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GEOFFREY OSBORNE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 apr 2024Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Damian Webb
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    David Frederick Shambrook
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0