VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED

VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00874784
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMPANY NUMBER 874784 LIMITED23 mar 200023 mar 2000
    AIR CALL COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED13 lug 198713 lug 1987
    AIR CALL LIMITED23 mar 196623 mar 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2007 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2006 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2016

    18 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2015

    19 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2014

    19 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2013

    19 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2012

    19 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2011

    19 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 feb 2010

    19 pagineRP04AR01

    Stato del capitale al 06 giu 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Andrew Michael Yorston come amministratore in data 02 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Diane Josephine Mcintyre come amministratore in data 16 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2016

    Stato del capitale al 03 mag 2016

    • Capitale: GBP 26,357,347
    SH01
    Note
    DataNota
    06 giu 2019Clarification A second filed AR01 was registered on 06/06/2019

    Chi sono gli amministratori di VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    DAVIS JR, Jefferson
    Suite 2800
    1100 Peach Tree Street
    4503 Atlanta
    Georgia 80309
    Usa
    Segretario
    Suite 2800
    1100 Peach Tree Street
    4503 Atlanta
    Georgia 80309
    Usa
    Us Citizen32812770003
    HOBLEY, Elizabeth Anne
    12 Spice Court
    Asher Way Wapping
    E1W 2JD London
    Segretario
    12 Spice Court
    Asher Way Wapping
    E1W 2JD London
    British85623090001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    SCOTT, Stephen Roy
    18 Tomlinson Drive
    Finchampstead
    RG40 3NZ Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    18 Tomlinson Drive
    Finchampstead
    RG40 3NZ Wokingham
    Berkshire
    British25660590002
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    Amministratore
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    British54076100002
    BENCARD, Robin Louis Henning
    31 Landford Road
    SW15 1AQ London
    Amministratore
    31 Landford Road
    SW15 1AQ London
    United KingdomBritish46782110002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHANNING WILLIAMS, David
    Three Cornered Hat
    Hamstead Marshall
    RG20 0HU Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Three Cornered Hat
    Hamstead Marshall
    RG20 0HU Newbury
    Berkshire
    British33481000001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COE, Charles Bruce
    1015 Redfield Terrace
    FOREIGN Dunwoody
    Georgia 30338
    Usa
    Amministratore
    1015 Redfield Terrace
    FOREIGN Dunwoody
    Georgia 30338
    Usa
    Us Citizen29688300001
    DILLON, Maria Therese
    Flat 1
    121 Canfield Gardens, South Hampstead
    NW6 3DY London
    Amministratore
    Flat 1
    121 Canfield Gardens, South Hampstead
    NW6 3DY London
    Irish127031280001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    British50867930001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British27272400002
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MAXWELL, Ian Ronald
    Wimbold Lodge
    Hatt Common
    RG20 0NH East Woodhay
    Berkshire
    Amministratore
    Wimbold Lodge
    Hatt Common
    RG20 0NH East Woodhay
    Berkshire
    British147577710001
    MCGEORGE, Kenneth Roy
    Pigshill View Manor Lane
    Baydon
    SN8 2JD Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Pigshill View Manor Lane
    Baydon
    SN8 2JD Marlborough
    Wiltshire
    British61230560001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    NEWLAND, David John
    Patience House
    Inkpen Road
    RG17 9UA Kintbury
    Berkshire
    Amministratore
    Patience House
    Inkpen Road
    RG17 9UA Kintbury
    Berkshire
    EnglandBritish93566140001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PAYNE, Michael Wakefield
    Locksley House
    Burys Bank Road
    RG19 8DB Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Locksley House
    Burys Bank Road
    RG19 8DB Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish116167740001
    PHILLIPS, Stephen Christopher
    Brook House
    Monkey Island Lane Bray
    SL6 2ED Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Brook House
    Monkey Island Lane Bray
    SL6 2ED Maidenhead
    Berkshire
    British36869120002
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    SMITH, John Bower
    Hazeldene
    Brackley Avenue
    RG27 8QX Hartley Wintney
    Hampshire
    Amministratore
    Hazeldene
    Brackley Avenue
    RG27 8QX Hartley Wintney
    Hampshire
    British102130390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2227940
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee agreement
    Creato il 12 nov 1986
    Consegnato il 19 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee not exceeding ukp 2,000,000. pursuant to a facility letter of even date and this guarantee
    Brevi particolari
    All stocks, shares bonds and securities and all other interests including but not limited to the loan capital of the company (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bellsouth Corporation
    Transazioni
    • 19 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1986
    Consegnato il 05 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    85 jesmond rd, newcastle upon tyne, 144 avenue rd, southampton, 72 queens rd, croydon, 16 watson place, plymouth, 59 walter rd, swansea, west glamorgan 18/20 lambeth high street, london SW1, 9 central hill, upper norwood, croydon, 233 derby rd, sandiaone, land and buildings on the north side of temple back, temple way, bristol.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 06 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ago 1985
    Consegnato il 21 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35,200
    Brevi particolari
    43 chepstow road, newport, gwent.
    Persone aventi diritto
    • Midshives Building Society
    Transazioni
    • 21 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 06 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1980
    Consegnato il 09 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 6-7 carven street ladywood, birmingham title no wm 59768.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1980
    Consegnato il 09 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H temple back temple way, bristol avon title no av 23375.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1980
    Consegnato il 09 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 4, jersey street, ancoats gr. Manchester title no gm 97690.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1980
    Consegnato il 09 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 18, lambeth high street lambeth london SE1. Title no sgl 230335.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0