ICAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàICAS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00877214
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ICAS LIMITED?

    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ICAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    14 Greville Street
    EC1N 8SB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ICAS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ICAS PUBLIC RELATIONS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    BAIN, DOUGLAS ASSOCIATES LIMITED19 apr 196619 apr 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di ICAS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ICAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Newgate Pr Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 gen 2022

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Sky Light City Tower 50 Basinghall Street London EC2V 5DE a 14 Greville Street London EC1N 8SB in data 10 gen 2022

    1 pagineAD01

    legacy

    96 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    legacy

    96 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Stato del capitale al 22 ott 2021

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of entire balance of the capital redemption reserve 08/10/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    21 pagineAA

    legacy

    136 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Mr Sergio Penna come amministratore in data 15 giu 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Federico Vecchio come amministratore in data 15 giu 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Louise Hannah Franklin come amministratore in data 21 mag 2020

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ICAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PENNA, Sergio
    Greville Street
    EC1N 8SB London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    Greville Street
    EC1N 8SB London
    14
    United Kingdom
    ItalyItalianGroup Cfo270840120001
    TAGLIABUE, Fiorenzo Vittorio
    Greville Street
    EC1N 8SB London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    Greville Street
    EC1N 8SB London
    14
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director264351440001
    COURTNEY, Carl Roger
    3 Vicarage Close
    Seer Green
    HP9 2QG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    3 Vicarage Close
    Seer Green
    HP9 2QG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British59735530003
    LAYTON, Anne Rosemary
    17 Webster Gardens
    Ealing
    W5 5NA London
    Segretario
    17 Webster Gardens
    Ealing
    W5 5NA London
    British34339620001
    BANKES, Rhydian
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    United KingdomBritishDirector231113900001
    COURTNEY, Carl Roger
    3 Vicarage Close
    Seer Green
    HP9 2QG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Vicarage Close
    Seer Green
    HP9 2QG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishPublic Relations Consultant59735530003
    COURTNEY, Kenneth Carl
    Valsheda Court Hythe Court
    Hythe Marina Village Hythe
    SO45 6DW Southampton
    Amministratore
    Valsheda Court Hythe Court
    Hythe Marina Village Hythe
    SO45 6DW Southampton
    EnglishCompany Director20680580002
    DEVINE, Gavin Richard
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    EnglandBritishCompany Director237060780001
    FRANKLIN, Louise Hannah
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    United KingdomBritishCompany Director261858110001
    GOLEMBIEWSKI, Eugene Gerard
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    England
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    England
    United KingdomAmericanFinance Director180263050005
    HARGREAVES, Tom
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    United KingdomBritishDirector155267550001
    HIGHET, Lindsay Margaret Stwart
    41 Highfield Way
    WD3 7PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Highfield Way
    WD3 7PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishDirector75085290001
    LAYTON, Anne Rosemary
    17 Webster Gardens
    Ealing
    W5 5NA London
    Amministratore
    17 Webster Gardens
    Ealing
    W5 5NA London
    EnglandBritishPublic Relations Consultant34339620001
    MCCAFFREY, Paul Michael
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    EnglandBritishConsumer Pr Consultant209079220001
    PITTHAM, Catherine Alice
    Tournay House
    13 Sutherland Road
    W13 0DY London
    Amministratore
    Tournay House
    13 Sutherland Road
    W13 0DY London
    BritishPublic Relations53722440001
    VECCHIO, Federico
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    United KingdomItalianGroup Cfo Of Sec Newgate264404240001
    WARD-WARING, Zoe
    Kimberley Road
    AL3 5PX St Albans
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kimberley Road
    AL3 5PX St Albans
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishPr Consultant113425310002
    WRIGHT, David Ernest
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    England
    Amministratore
    50 Basinghall Street
    EC2V 5DE London
    Sky Light City Tower
    England
    EnglandBritishCompany Director14119160008
    WRIGHT, Kathleen Emma
    Charles Street
    HP4 3DF Berkhamsted
    12
    Hertfordshire
    Amministratore
    Charles Street
    HP4 3DF Berkhamsted
    12
    Hertfordshire
    United KingdomBritishPr Consultant86195590002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ICAS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Greville Street
    EC1N 8SB London
    14
    England
    06 apr 2016
    Greville Street
    EC1N 8SB London
    14
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione7676949
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ICAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 giu 2017
    Consegnato il 15 giu 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 15 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 dic 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2015
    Consegnato il 09 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 09 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 apr 2015
    Consegnato il 24 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hawk Investment Holdings Limited
    Transazioni
    • 24 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 19 gen 2015
    Consegnato il 20 gen 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Retro Grand Limited
    Transazioni
    • 20 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 feb 2010
    Consegnato il 04 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Central Securities Limited
    Transazioni
    • 04 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 set 2006
    Consegnato il 03 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 04 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of deposit
    Creato il 01 lug 1998
    Consegnato il 11 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £6,325 and all interest and other monies.
    Persone aventi diritto
    • David Lawrence Levy and Veronica Ashley Collins
    Transazioni
    • 11 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of deposit
    Creato il 01 lug 1998
    Consegnato il 11 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £5,375 and all interest and other monies.
    Persone aventi diritto
    • David Lawrence Levy and Veronica Ashley Collins
    Transazioni
    • 11 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0