ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD

ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00880172
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    Cheshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALTAIR FILTERS INTERNATIONAL LIMITED19 lug 198419 lug 1984
    ALTAIR VENTILATION PRODUCTS LIMITED26 mag 196626 mag 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di James Edward Dennison come amministratore in data 01 lug 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Shona Clare Searle come amministratore in data 01 lug 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione di Ge Energy Services (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 03 mag 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di General Electric Uk Holdings Ltd. come persona con controllo significativo il 03 mag 2022

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 27 lug 2021

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    21 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Seconda presentazione per la nomina di James Edward Dennison come amministratore

    3 pagineRP04AP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 pagineAD04

    Dettagli del direttore cambiati per James Edward Dennison il 31 lug 2019

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT in data 31 lug 2019

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Ge Energy Services (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 31 lug 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Timothy Robert Hill come amministratore in data 24 set 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    SEARLE, Shona Clare
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant And Chartered Tax Advisor203330870002
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Segretario
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    AmericanDirector111641000001
    HEGARTY, Colin Michael
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    Segretario
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    British14062610002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOYCE, Christian Jeremy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSite Leader174484350001
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Amministratore
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    AmericanDirector111641000001
    CARSON, Candace
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    Amministratore
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    AmericanDirector111758740001
    CHURCH, Ian Harold
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    Amministratore
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    BritishDirector1750390002
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishLegal Counsel56868460002
    CLEAVER, Roy Edward
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    BritishDirector21416960002
    DENNISON, James Edward
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Director250786800001
    ELSDON, Peter John
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director Accountant67751830001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    GRIFFITHS, David Maxwell
    1 Shepherds Down
    SO24 9PP Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    1 Shepherds Down
    SO24 9PP Alresford
    Hampshire
    BritishEngineer88087440001
    HEGARTY, Colin Michael
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    Amministratore
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant14062610002
    HEINTZELMAN, Daniel
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    Amministratore
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    AmericanGeneral Manager111641060001
    HILL, Timothy Robert
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant183650700001
    HINTON, David Ian Small
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector21416950001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Amministratore
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    BritishUk Controller Ge Energy106985300001
    LEWIS, Peter
    Mount Cottage
    Winchester Road
    SO21 3DG Micheldever
    Hampshire
    Amministratore
    Mount Cottage
    Winchester Road
    SO21 3DG Micheldever
    Hampshire
    BritishSales Director87730480002
    RICHARDSON, Paul
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGlobal Projects Leader174494740001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector203364460001
    SENNETT, Paul Timothy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNone174484310001
    STEEL, Andrew Charles
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    Amministratore
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director33164070002
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Manager96648390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Harry Kerr Drive
    ST16 1WT Stafford
    St Leonards Building
    Staffordshire
    United Kingdom
    03 mag 2022
    Harry Kerr Drive
    ST16 1WT Stafford
    St Leonards Building
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4267912
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2330098
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    29 nov 201601 dic 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 12 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The South Place Gresham Partnership 2002 Acting as Security Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 12 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 07 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Gurantee & debenture
    Creato il 21 set 1989
    Consegnato il 02 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 set 1989
    Consegnato il 02 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 3 omega park, wilson road, alton, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 21 set 1989
    Consegnato il 25 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from appfire limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 25 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1987
    Consegnato il 01 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the property k/a cherry st. Woking surrey T.N.'s sy- 437983 & sy 479922.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1987
    Consegnato il 20 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a plot 3 omega park alton hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1986
    Consegnato il 04 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to the south east of cherry street, woking, surrey, t/no. Sy 479922.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 01 feb 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 giu 1985
    Consegnato il 12 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1983
    Consegnato il 24 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the S.E. of cherry st., Woking, surrey. Title no. Sy 479922.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1983
    Consegnato il 24 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & building lying to the east of cherry street, woking, surrey title no. Sy 437983.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 25 ago 1983
    Consegnato il 01 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0