ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD
Panoramica
Nome della società | ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00880172 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Indirizzo della sede legale | 3rd Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham Cheshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ALTAIR FILTERS INTERNATIONAL LIMITED | 19 lug 1984 | 19 lug 1984 |
ALTAIR VENTILATION PRODUCTS LIMITED | 26 mag 1966 | 26 mag 1966 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Edward Dennison come amministratore in data 01 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Shona Clare Searle come amministratore in data 01 lug 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione di Ge Energy Services (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 03 mag 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di General Electric Uk Holdings Ltd. come persona con controllo significativo il 03 mag 2022 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 27 lug 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Seconda presentazione per la nomina di James Edward Dennison come amministratore | 3 pagine | RP04AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per James Edward Dennison il 31 lug 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT in data 31 lug 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Ge Energy Services (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 31 lug 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Robert Hill come amministratore in data 24 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
SEARLE, Shona Clare | Amministratore | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant And Chartered Tax Advisor | 203330870002 | ||||||||
BURKE, Mary | Segretario | 4471 Chattahoochie Plantation Drive FOREIGN Marietta Georgia 30067 Usa | American | Director | 111641000001 | |||||||||
HEGARTY, Colin Michael | Segretario | 15 Cornfields GU46 6YT Yateley Hampshire | British | 14062610002 | ||||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
BOYCE, Christian Jeremy | Amministratore | Omega Park GU34 2QE Alton 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Site Leader | 174484350001 | ||||||||
BURKE, Mary | Amministratore | 4471 Chattahoochie Plantation Drive FOREIGN Marietta Georgia 30067 Usa | American | Director | 111641000001 | |||||||||
CARSON, Candace | Amministratore | 653 Briarleigh Way FOREIGN Woodstock Georgia 30189 America | American | Director | 111758740001 | |||||||||
CHURCH, Ian Harold | Amministratore | 25 Fairlawn Park GU21 4HT Woking Surrey | British | Director | 1750390002 | |||||||||
CLARK, Alyson Margaret | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Legal Counsel | 56868460002 | ||||||||
CLEAVER, Roy Edward | Amministratore | Hill House Brightstone Lane Farringdon GU34 3ET Alton Hampshire | British | Director | 21416960002 | |||||||||
DENNISON, James Edward | Amministratore | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tax Director | 250786800001 | ||||||||
ELSDON, Peter John | Amministratore | Chase Warren Tennysons Lane GU27 3AF Haslemere Surrey | United Kingdom | British | Company Director Accountant | 67751830001 | ||||||||
EVERETT, Peter Daryl | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | England | British | Tax Manager | 127244240001 | ||||||||
EVERETT, Peter Daryl | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | England | British | Tax Manager | 127244240001 | ||||||||
GRIFFITHS, David Maxwell | Amministratore | 1 Shepherds Down SO24 9PP Alresford Hampshire | British | Engineer | 88087440001 | |||||||||
HEGARTY, Colin Michael | Amministratore | 15 Cornfields GU46 6YT Yateley Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 14062610002 | ||||||||
HEINTZELMAN, Daniel | Amministratore | 5116 Sapphire Drive FOREIGN Marietta Georgia 30066 Usa | American | General Manager | 111641060001 | |||||||||
HILL, Timothy Robert | Amministratore | The Arena Downshire Way RG12 1PU Bracknell No 2 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 183650700001 | ||||||||
HINTON, David Ian Small | Amministratore | The Old Brewery Hilltop Chichester Road GU29 9PZ Midhurst West Sussex | United Kingdom | British | Director | 21416950001 | ||||||||
KEENAN, John Joseph | Amministratore | 5 Gresham Road CM14 4HN Brentwood Essex | British | Uk Controller Ge Energy | 106985300001 | |||||||||
LEWIS, Peter | Amministratore | Mount Cottage Winchester Road SO21 3DG Micheldever Hampshire | British | Sales Director | 87730480002 | |||||||||
RICHARDSON, Paul | Amministratore | Omega Park GU34 2QE Alton 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Global Projects Leader | 174494740001 | ||||||||
ROBERTSON, Moria Ann | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire | United Kingdom | British | Director | 203364460001 | ||||||||
SENNETT, Paul Timothy | Amministratore | Omega Park GU34 2QE Alton 3 Hampshire United Kingdom | England | British | None | 174484310001 | ||||||||
STEEL, Andrew Charles | Amministratore | 9 Clumps Road Lower Bourne GU10 3HF Farnham Surrey | England | British | Managing Director | 33164070002 | ||||||||
WAKE, Hilary Anne, Mrs. | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tax Manager | 96648390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric Uk Holdings Ltd. | 03 mag 2022 | Harry Kerr Drive ST16 1WT Stafford St Leonards Building Staffordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Ge Energy Services (Uk) Limited | 06 apr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
29 nov 2016 | 01 dic 2017 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creato il 01 feb 2003 Consegnato il 12 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 feb 2003 Consegnato il 07 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Gurantee & debenture | Creato il 21 set 1989 Consegnato il 02 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 set 1989 Consegnato il 02 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plot 3 omega park, wilson road, alton, hampshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Collateral debenture | Creato il 21 set 1989 Consegnato il 25 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from appfire limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 ago 1987 Consegnato il 01 set 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the property k/a cherry st. Woking surrey T.N.'s sy- 437983 & sy 479922. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 ago 1987 Consegnato il 20 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a plot 3 omega park alton hampshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 nov 1986 Consegnato il 04 dic 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land to the south east of cherry street, woking, surrey, t/no. Sy 479922. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 01 feb 1986 Consegnato il 04 feb 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 25 giu 1985 Consegnato il 12 lug 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 nov 1983 Consegnato il 24 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land lying to the S.E. of cherry st., Woking, surrey. Title no. Sy 479922. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 nov 1983 Consegnato il 24 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & building lying to the east of cherry street, woking, surrey title no. Sy 437983. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 ago 1983 Consegnato il 01 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0