DIXON VEHICLE SALES LIMITED

DIXON VEHICLE SALES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIXON VEHICLE SALES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00882224
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARNELL MOTOR GROUP LIMITED27 giu 196627 giu 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Princes Street London EC2R 8BP England a 250 Bishopsgate London EC2M 4AA in data 04 nov 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 set 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Natwest Group Secretarial Services Limited il 03 ago 2020

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Stevens il 27 ago 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gary Moore il 27 ago 2021

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Lombard North Central Plc come persona con controllo significativo il 25 nov 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Rbs Secretarial Services Limited il 16 set 2020

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Princes Street London EC2R 8PB a 1 Princes Street London EC2R 8BP in data 07 nov 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Mark Stevens come amministratore in data 30 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sally Jane Sutherland come amministratore in data 30 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 set 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Notifica di Lombard North Central Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Gary Moore come amministratore in data 01 giu 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew James Nicholson come amministratore in data 31 mag 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830002
    MOORE, Gary
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    ScotlandBritish247794910001
    STEVENS, Mark
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    United KingdomBritish262912910001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Segretario
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    CUTHBERTSON, Garry
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    Segretario
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    British54577250002
    FRANKS, Ian Charles
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    Segretario
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    British71584820001
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Segretario
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    British34423910002
    POTTER, Stephen John
    120 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AH Bedford
    Segretario
    120 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AH Bedford
    British104934960001
    REAH, Raymond
    Gillrae 28 Willow Glen
    Branton
    DN3 3JD Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Gillrae 28 Willow Glen
    Branton
    DN3 3JD Doncaster
    South Yorkshire
    British16687160001
    RUSSELL, Christine Anne
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    164016450001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    BOWLER, Peter Martin
    8 Blenheim Rise
    Bawtry
    DN10 6SF Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    8 Blenheim Rise
    Bawtry
    DN10 6SF Doncaster
    South Yorkshire
    British75280390002
    BRUSHFIELD, Jocelyn Nadauld
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    Amministratore
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    EnglandBritish160922120001
    CARNELL, Andrew Stephen
    21 Queensgate
    HG1 5RQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    21 Queensgate
    HG1 5RQ Harrogate
    North Yorkshire
    British81113960001
    CARNELL, Martyn Dennis
    The Old Vicarage Church Street
    Everton
    DN10 5BB Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage Church Street
    Everton
    DN10 5BB Doncaster
    South Yorkshire
    British11237330001
    CARNELL, Paul James
    34 Warnington Drive
    Bessacarr
    DN4 6SU Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    34 Warnington Drive
    Bessacarr
    DN4 6SU Doncaster
    South Yorkshire
    British11237310001
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    British38897330001
    CUTHBERTSON, Garry
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish54577250002
    DIXON, Paul William Henry
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    Amministratore
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    United KingdomBritish153357310001
    DIXON, Simon Timothy
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish101291990002
    HOPKINS, Richard James
    Flat 4 Kings View Court
    115 Ridgway Wimbledon
    SW19 4RW London
    Amministratore
    Flat 4 Kings View Court
    115 Ridgway Wimbledon
    SW19 4RW London
    EnglandBritish92378040002
    JACKSON, James Anthony
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London,
    280
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London,
    280
    England
    EnglandBritish154943750001
    LAMBERT, Mark Andrew
    Owls Castle Cottage
    Hog Hole Lane, Lamberhurst
    TN3 8BN Tunbridge Wells
    Amministratore
    Owls Castle Cottage
    Hog Hole Lane, Lamberhurst
    TN3 8BN Tunbridge Wells
    EnglandBritish150167790001
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Amministratore
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    EnglandBritish34423910002
    MACARTHUR, Neil Clark
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritish81529340002
    NICHOLSON, Andrew James
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish163664680002
    PEPPARD, Anthony Edward
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    Irish76520410001
    POTTER, Stephen John
    120 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AH Bedford
    Amministratore
    120 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AH Bedford
    EnglandBritish104934960001
    RAMANATHAN, Shankar
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    Amministratore
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    EnglandBritish125663610001
    REAH, Raymond
    Gillrae 28 Willow Glen
    Branton
    DN3 3JD Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Gillrae 28 Willow Glen
    Branton
    DN3 3JD Doncaster
    South Yorkshire
    British16687160001
    SHIRLEY, Victor Frederick
    1 Norman Road
    Hatfield
    DN7 6AF Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    1 Norman Road
    Hatfield
    DN7 6AF Doncaster
    South Yorkshire
    British43337920001
    STANWORTH, Mark
    45 Park Avenue
    Shelley
    HD8 8JY Huddersfield
    Amministratore
    45 Park Avenue
    Shelley
    HD8 8JY Huddersfield
    United KingdomBritish67885350001
    STEWART, Gary Robert Mcneilly
    Burnbrae Avenue
    EH12 8AU Edinburgh
    10
    Scotland
    Amministratore
    Burnbrae Avenue
    EH12 8AU Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish128173150002
    SUTHERLAND, Sally Jane
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish166757310001
    TEALE, Andrew Richard
    98 The Stray Littlewold Lane
    HU15 2AL South Cave
    North Humberside
    Amministratore
    98 The Stray Littlewold Lane
    HU15 2AL South Cave
    North Humberside
    British75058100001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DIXON VEHICLE SALES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    06 apr 2016
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Companies Acts
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00337004
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    DIXON VEHICLE SALES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture between dixon motors PLC certain of its subsidiaries (including the company) and the royal bank of scotland PLC as security agent and trustee for the lenders (as defined)
    Creato il 01 feb 1999
    Consegnato il 03 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each designated finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south side of market street grimsby t/no: HS199863; f/h land k/a 271-291 bury new road and 8, 10 and 12 hilton street salford t/no: GM118716; f/h land k/a 206-206(a) great clowes street salford t/no: LA70372. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 21 ago 1997
    Consegnato il 09 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) due or to become due from the company to the chargee and to each lender (as defined) under each designated finance document (as defined)
    Brevi particolari
    All of the property listed in schedule 2 to the debenture and/or in the schedule to the deed of accession .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 09 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Creato il 21 mag 1997
    Consegnato il 22 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company in sub leases now made or hereafter to be made by the company in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements now or hereafter made between the chargee and the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 22 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 mag 1995
    Consegnato il 16 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Showroom and garage premises at park road glasshoughton castleford west yorkshire with all fixtures and fittings plant and machinery and with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    Land east of low lane leeds west yoks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 mag 1994
    Consegnato il 21 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms off the deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    All monies owing to the company in respect of refunds paid by way of deposit on the acquistion of motor vehicles on a consignment basis. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 feb 1994
    Consegnato il 04 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture (as defined therein)
    Brevi particolari
    All monies from time to time owing to the company by V.A.G. (united kingdom) in respect of refunds and monies paid by way of deposit on acquisition of motor vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 04 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 gen 1994
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to south west of marshgate doncaster south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 ott 1993
    Consegnato il 11 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over land and buildings lying to the south west of marshgate doncaster south yorkshire and with all fixtures and fittings other than trade fixtures and fittings together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 17 mag 1993
    Consegnato il 18 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All new and usedr cars car-derived vans and light commercial vehicles and all the dealers right title and interest under the dealer agreement.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 18 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Car park area marshgate doncaster southgate. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Warehouse and front area marshgate motors showroom. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Main showroom and adjacent display area marshgate motors showroom doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1992
    Consegnato il 14 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 5,7,9,11,13,15,17,19,21,bethel road rotherham S. yorks.with f/h land at fitzwilliam road rotherham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 set 1990
    Consegnato il 20 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of charge
    Brevi particolari
    All monies from time to time owing to the company in respect of refunds of monies paid by way of deposit acquisition of motor vehicles on a consignment basis (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 20 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 07 set 1989
    Consegnato il 11 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under trustees of the charge
    Brevi particolari
    All new and unused cars, car-derived vans and light commercial vehicles manufactured by S.A. automobiles citroen (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 11 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H plot of land to the south east side of thorne road doncaster south yorkshire of approx 1.3 acres.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 giu 1986
    Consegnato il 02 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the charger's interest (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 02 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed
    Creato il 09 nov 1984
    Consegnato il 22 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or carnell motor group (alwoodley) limited and/or carnell motor group (horsforth) limited and/or humberside motor cycle centres limited to the chargee supplemental to a debenture dated 3RD january 1972
    Brevi particolari
    All the property comprised in the debenture dated 3RD january 1972 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures) (see form doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 22 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1983
    Consegnato il 29 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot of land containing approximately 2.1 acres situate at 125 low road horsforth near leeds in the conty of west yorkshire title no: wyk 174486.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1983
    Consegnato il 29 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot of land containing approximately 1.4 acres situate at harrogate road, alwoodley leeds in the county of south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1981
    Consegnato il 27 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H 34, warnington drive bessacarr, doncaster, S. yorks.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture mortgage debenture
    Creato il 11 mar 1981
    Consegnato il 14 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a letter dated 3.2.81
    Brevi particolari
    All these monies which may from time to time be owing to barnell motor group limited by datsun (UK) limited in respect of monies paid by or by direction of the company by way of deposit on the qcquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds and Scottish Trust Limited
    Transazioni
    • 14 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 feb 1981
    Consegnato il 25 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property being land & buildings situate on the south side of george street wakefield west yorkshire title no wyk 70253.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 feb 1981
    Consegnato il 17 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land (approx 1.27 acres) situate on the marshgate industrial estate, doncaster, south yorkshire, together with all buildings.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0