GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED

GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00882788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor Westfield House
    S1 3FZ 60 Charter Row
    Sheffield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LOCAT LIMITED04 nov 199204 nov 1992
    KARMA INDUSTRIES LIMITED01 mag 199101 mag 1991
    GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED04 lug 196604 lug 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagineLIQ13

    Soddisfazione dell'onere 008827880010 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2022

    6 pagineAA

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bradshaw Works Swinston Hill Road Dinnington Sheffield S25 2RY a 3rd Floor Westfield House 60 Charter Row Sheffield S1 3FZ in data 18 apr 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mar 2023

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2015

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STATON, Trevor
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    Segretario
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    British16526030001
    GRAY, Julian
    Briersoak Barn
    Briers House Lane, Dungworth, Nr Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Briersoak Barn
    Briers House Lane, Dungworth, Nr Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish112961150001
    STATON, Trevor
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish16526030001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    MCCLURE, Sallie Jane
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Segretario
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    British42907450001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    CLARKSON, Anthony George
    50 Woodstock Road
    S75 1DX Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    50 Woodstock Road
    S75 1DX Barnsley
    South Yorkshire
    United KingdomBritish42906860001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    DAY, Alan Raymond
    Stenton Farm
    50 High Street, Laughton
    S25 1YF Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Stenton Farm
    50 High Street, Laughton
    S25 1YF Sheffield
    South Yorkshire
    British42907340002
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    GARSIDE, Garry
    21 School Lane
    Stainton
    S66 7QX Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    21 School Lane
    Stainton
    S66 7QX Rotherham
    South Yorkshire
    British42907360001
    HINCHCLIFFE, Alan
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    Amministratore
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    EnglandBritish86931130002
    MCCLURE, Jeffrey Turner
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritish42906710001
    MCCLURE, Jeffrey Turner
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritish42906710001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001
    WRIGHT, Stephen Michael
    98 Deerlands Road
    Wingerworth
    S42 6XA Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    98 Deerlands Road
    Wingerworth
    S42 6XA Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish112961140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Julian Gray
    Briers House Lane
    Dungworth, Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    Briersoak Barn
    England
    01 feb 2017
    Briers House Lane
    Dungworth, Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    Briersoak Barn
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Trevor Staton
    Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    19
    England
    01 feb 2017
    Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    19
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Tjs Holdings Ltd
    Swinston Hill Road
    Dinnington
    S25 2RY Sheffield
    Bradshaw Works
    England
    01 feb 2017
    Swinston Hill Road
    Dinnington
    S25 2RY Sheffield
    Bradshaw Works
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione05823840
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 gen 2016
    Consegnato il 15 gen 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 nov 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 dic 2010
    Consegnato il 31 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 feb 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 2009
    Consegnato il 10 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or tjs holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land and buildings on the south east side of first lane harry crofts south anston rotherham south yorkshire t/n SYK371323.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 feb 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 set 2009
    Consegnato il 01 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 07 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a harry crofts works first lane south anston sheffield south yorkshire t/no SYK371323. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 07 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a harry crofts works first lane south anston sheffield south yorkshire t/no SYK371323. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 mar 1995
    Consegnato il 01 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 11 ott 1993
    Consegnato il 13 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 20/03/90
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 1990
    Consegnato il 05 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 mar 1990
    Consegnato il 26 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mar 2023Inizio della liquidazione
    23 feb 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kris Anthony Wigfield
    3rd Floor Wakefield House Charter Row
    Number 60
    S1 3FZ Sheffield
    South Yorkshire
    Praticante
    3rd Floor Wakefield House Charter Row
    Number 60
    S1 3FZ Sheffield
    South Yorkshire
    Philip David Nunney
    3rd Floor Westfield House
    60 Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Praticante
    3rd Floor Westfield House
    60 Charter Row
    S1 3FZ Sheffield

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0