ASW SHEERNESS STEEL LIMITED

ASW SHEERNESS STEEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASW SHEERNESS STEEL LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00882919
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    • (2710) /

    Dove si trova ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Grant Thornton
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CO-STEEL SHEERNESS P.L.C.22 dic 199222 dic 1992
    SHEERNESS STEEL COMPANY P. L. C.05 lug 196605 lug 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2001
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2002
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al07 lug 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma21 lug 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92
    R4FBVXLU

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92
    R1LMBB7M

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72
    AC69MCIH

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 giu 2009

    5 pagine4.68
    AY68PB9V

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 dic 2008

    5 pagine4.68
    AMZHG6EC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 dic 2008

    5 pagine4.68
    ADGAE180

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Varie

    Sec of state's release of liq
    1 pagineMISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione delle attività

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Chi sono gli amministratori di ASW SHEERNESS STEEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARTLETT, George Derek Wilson
    Copse Hill 58 Pentre Poeth Road
    Bassaleg
    NP10 8LL Newport
    Gwent
    Segretario
    Copse Hill 58 Pentre Poeth Road
    Bassaleg
    NP10 8LL Newport
    Gwent
    British33320770001
    BARTLETT, George Derek Wilson
    Copse Hill 58 Pentre Poeth Road
    Bassaleg
    NP10 8LL Newport
    Gwent
    Amministratore
    Copse Hill 58 Pentre Poeth Road
    Bassaleg
    NP10 8LL Newport
    Gwent
    United KingdomBritishChartered Secretary33320770001
    JUDD, Robert Edward
    13 Lady Mary Road
    Roath
    CF23 5NS Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    13 Lady Mary Road
    Roath
    CF23 5NS Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCompany Director74912930001
    MACKENZIE, Graham Roche
    Hollow Tree House Hollow Tree Lane
    Tardebigge
    B60 1PR Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    Hollow Tree House Hollow Tree Lane
    Tardebigge
    B60 1PR Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director14143200001
    BELL, George
    Wiltons Newnham Lane
    Eastling
    ME13 0AS Faversham
    Kent
    Segretario
    Wiltons Newnham Lane
    Eastling
    ME13 0AS Faversham
    Kent
    British51827870001
    O'CALLAGHAN, Perry Charles
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    Segretario
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    British30363240003
    BELL, George
    Wiltons Newnham Lane
    Eastling
    ME13 0AS Faversham
    Kent
    Amministratore
    Wiltons Newnham Lane
    Eastling
    ME13 0AS Faversham
    Kent
    BritishDirector51827870001
    BILLOT, Hugh Edward, Dr
    Randolphs Leap Pluckley Road
    Charing
    TN27 0AG Ashford
    Kent
    Amministratore
    Randolphs Leap Pluckley Road
    Charing
    TN27 0AG Ashford
    Kent
    United KingdomBritishDirector39608830001
    CLAYTON, John William
    West Court Oast
    The Street
    ME14 3JU Detling
    Kent
    Amministratore
    West Court Oast
    The Street
    ME14 3JU Detling
    Kent
    EnglandBritishDirector116097970001
    COURT, Justin Southworth
    Flat 11 Cardinal Mansions
    Carlisle Place
    SW1P 1EY London
    Amministratore
    Flat 11 Cardinal Mansions
    Carlisle Place
    SW1P 1EY London
    United KingdomBritishChartered Accountant98094250001
    FOURNIER, Ronald Paul
    131 Glen Road
    Toronto Ontario M4w 2w4
    FOREIGN
    Canada
    Amministratore
    131 Glen Road
    Toronto Ontario M4w 2w4
    FOREIGN
    Canada
    CanadianCompany Director12263910001
    HEFFERNAN, George Robert
    G R Heffernan Associates
    22 St Claire Avenue East Toronto Ontario M4t 2s3
    FOREIGN
    Canada
    Amministratore
    G R Heffernan Associates
    22 St Claire Avenue East Toronto Ontario M4t 2s3
    FOREIGN
    Canada
    CanadianSteel Company Executive14111590001
    HUTCHINSON, Lew Cameron
    1121 Wesdale Road
    Lot 12 Oakville Ontario
    FOREIGN L6l 6j5 Canada
    Amministratore
    1121 Wesdale Road
    Lot 12 Oakville Ontario
    FOREIGN L6l 6j5 Canada
    CanadianExecutive54754590002
    KIDNIE, Elizabeth
    11 Markwood Crescent
    M9C 1LI Etobicoke
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    11 Markwood Crescent
    M9C 1LI Etobicoke
    Ontario
    Canada
    CanadianVp Finance Cfo59533610001
    KOERNER, Michael
    Suite 5010 Scotia Plaza
    PO BOX 130 40 King Street West
    FOREIGN Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    Suite 5010 Scotia Plaza
    PO BOX 130 40 King Street West
    FOREIGN Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianInvestment Company Executive16084810001
    LEARMOND, Peter Alexander
    Anvil Cottage
    Conford
    GU30 7QW Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    Anvil Cottage
    Conford
    GU30 7QW Liphook
    Hampshire
    BritishDeputy Chairman35551270001
    MORRIS, Charles Evan Henry
    Old Forge House The Lees Boughton Aluph
    TN25 4JB Ashford
    Kent
    Amministratore
    Old Forge House The Lees Boughton Aluph
    TN25 4JB Ashford
    Kent
    BritishChief Executive12130110001
    NEWMAN, Terry Garnell
    128 Long Water Chase
    Unionville L3r 6d4
    FOREIGN Ontario Canada
    Amministratore
    128 Long Water Chase
    Unionville L3r 6d4
    FOREIGN Ontario Canada
    AmericanExecutive68511990001
    ORAM, Brian Denis
    Wharf House 10 Martinslade
    Seend
    SN12 6RT Melksham
    Wiltshire
    Amministratore
    Wharf House 10 Martinslade
    Seend
    SN12 6RT Melksham
    Wiltshire
    BritishCompany Director3965750001
    PHILIPP, Wolfgang Hermann
    Cappenberger Damm 31
    D-59379 Selm
    Germany
    Amministratore
    Cappenberger Damm 31
    D-59379 Selm
    Germany
    GermanConsultant39031560002
    SCHIPPER, Lionel
    Suite 1010
    22 St Clair Avenue East Toronto Ontario N4t2 2s3
    FOREIGN
    Canada
    Amministratore
    Suite 1010
    22 St Clair Avenue East Toronto Ontario N4t2 2s3
    FOREIGN
    Canada
    CanadianInvestment Company Executive14111550001
    SCHMELZLE, Christopher G
    1015 Sunnyside Road
    Kolowna British Columbia V1z 2n7
    FOREIGN
    Canada
    Amministratore
    1015 Sunnyside Road
    Kolowna British Columbia V1z 2n7
    FOREIGN
    Canada
    CanadianDirector14111560001
    SHEEHAN, Gerald
    St Julians Farm
    Old St Mellons
    CF3 6YJ Cardiff
    Amministratore
    St Julians Farm
    Old St Mellons
    CF3 6YJ Cardiff
    United KingdomBritishCompany Director117748710001
    SHIELDS, William James
    40 King Street
    W PO BOX 130
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5h 3y2
    Canada
    Amministratore
    40 King Street
    W PO BOX 130
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5h 3y2
    Canada
    Us CitizenDirector31136780001
    SHIRLEY, Martin John
    Burnham House
    The Street Bredgar
    ME9 8EX Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    Burnham House
    The Street Bredgar
    ME9 8EX Sittingbourne
    Kent
    BritishDirector105167270001
    SMITH, Michael Graham
    Argrove House
    Elvington Lane Hawkinge
    CT18 7AD Folkestone
    Kent
    Amministratore
    Argrove House
    Elvington Lane Hawkinge
    CT18 7AD Folkestone
    Kent
    BritishDirector34066990001
    TOWNSEND, Edward Charles
    Llwyn Celyn
    Llansoar Caerleon
    NP6 1LS Newport
    Gwent
    Amministratore
    Llwyn Celyn
    Llansoar Caerleon
    NP6 1LS Newport
    Gwent
    BritishCompany Director45590660001
    WAISBERG, Lorie
    602 Lonsdale Road
    Toronto M5p 1r7
    FOREIGN Ontario Canada
    Amministratore
    602 Lonsdale Road
    Toronto M5p 1r7
    FOREIGN Ontario Canada
    CanadianLawyer61061120001

    ASW SHEERNESS STEEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 21 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.(Including Its Successors)
    Transazioni
    • 21 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1999
    Consegnato il 27 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor (as defined) to the trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (as defined) on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) including the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(The "Trustee")
    Transazioni
    • 27 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 lug 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 04 mar 2004Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 27 apr 2004Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1
    Debenture
    Creato il 28 set 1989
    Consegnato il 13 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the debenture.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1989
    Consegnato il 05 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto Dominion Bank
    Transazioni
    • 05 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sixth supplemental trust deed
    Creato il 03 mar 1983
    Consegnato il 23 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,258,362 10 3/4 per cent sterling loan stock 1983 under the terms of a trust deed dated 1-2-71 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking charges over undertaking and all propery and assets present and future including goodwill uncalled capital. And certain fixed assets specified in the trust deed. (See doc M85).
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 23 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 giu 1982
    Consegnato il 11 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 8.6.82.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital tog. With all bldgs. & fixtures (inc. Trade fixtures) inc. Heritable property assets & rights in scotland. The fixed assets described in schedule 4 to the debenture and all replacements of such items. (See doc. M84).
    Persone aventi diritto
    • First National Bank in Dallas
    • Hambros Bank Limited
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 11 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 giu 1982
    Consegnato il 11 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a recourse agreement
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Tog. With all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery inc. Hertable property, assets & rights in scotland. The fixed assets described in schedule 3 to the debenture and all replacements of such terms (see doc. M83).
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade
    Transazioni
    • 11 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 28 feb 1979
    Consegnato il 15 mar 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (A) l/h property at ridham, sittingbourne, kent. Title no k 463389. (b) first fixed charge the car fragmentation plant situated on the property at (a) and all replacements thereof. (C) by way of assignment the benefit of all buildings policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal and fixed charge
    Creato il 28 feb 1979
    Consegnato il 01 mar 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 18 october 1978
    Brevi particolari
    F/Hold property at ridham, sittingbourne, kent title no. K 463389 with all bldgs and fixtures (excluding trade fixtures) the car fragmentation situate upon the property mentioned above and all replacements and repairs thereto.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto Dominion Bank
    Transazioni
    • 01 mar 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASW SHEERNESS STEEL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 gen 1999Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    R.H. H Oldfield
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC3P 3BS London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC3P 3BS London
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    09 giu 2003Inizio della liquidazione
    20 nov 2009Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Michael Hawes
    Grant Thornton
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Praticante
    Grant Thornton
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    David Thomas
    11-13 Penhill Road
    Cardiff
    CF1 9UP
    Praticante
    11-13 Penhill Road
    Cardiff
    CF1 9UP

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0