DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED

DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00886108
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Victoria House Bloomsbury Square
    Southampton Row
    WC1B 4DA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LOUISVILLE INVESTMENTS (UXBRIDGE) LIMITED22 ago 196622 ago 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Michael Whelan come amministratore in data 28 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 mar 2011

    Stato del capitale al 22 mar 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    15 pagineAA

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Stephen Traub come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Traub come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2007

    14 pagineAA

    Stato patrimoniale

    7 pagineSA

    legacy

    2 pagine88(2)R

    Chi sono gli amministratori di DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARRETT, John
    29 Milltown Avenue
    Mount St Annes
    IRISH Milltown
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    29 Milltown Avenue
    Mount St Annes
    IRISH Milltown
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish89358820002
    WHELAN, Michael
    Bloomsbury Square
    Southampton Row
    WC1B 4DA London
    Victoria House
    Amministratore
    Bloomsbury Square
    Southampton Row
    WC1B 4DA London
    Victoria House
    IrelandIrish164245970001
    ALLARD, Tyrone James
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Segretario
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Irish2343150005
    CAINES, Geoffrey Harold
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    Segretario
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    British22701030002
    PRICE, John Dewi Brychan
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    Segretario
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    British3041640002
    TRAUB, Stephen Eric Cameron
    Norwood Drive
    BT4 2EA Belfast
    22
    County Antrim
    United Kingdom
    Segretario
    Norwood Drive
    BT4 2EA Belfast
    22
    County Antrim
    United Kingdom
    British143642110001
    MEPC SECRETARIES LIMITED
    103 Wigmore Street
    W1U 1AH London
    Segretario
    103 Wigmore Street
    W1U 1AH London
    79708020001
    ALLARD, Tyrone James
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish2343150005
    BARWICK, Charles Julian
    8 Belgrave Road
    SW13 9NS London
    Amministratore
    8 Belgrave Road
    SW13 9NS London
    EnglandBritish3818640001
    BATCHELOR, Peter Andrew
    Flat 269 North County Hall
    1c Belvedere Road
    SE1 7GF London
    Amministratore
    Flat 269 North County Hall
    1c Belvedere Road
    SE1 7GF London
    British68594020002
    BATKIN, John Windsor
    11 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AB Rickmansworth
    Hertfordshire
    British2049170001
    CAINES, Geoffrey Harold
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    Amministratore
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    EnglandBritish22701030002
    COURTAULD, Toby Augustine
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    Amministratore
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    British46882260003
    DIBLEY, Hugh Leslie Stewart
    Morrisdown
    Piltdown
    TN22 3XU Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Morrisdown
    Piltdown
    TN22 3XU Uckfield
    East Sussex
    British2012160001
    DUNN, Peter Harold
    10 High Street
    TW12 2SJ Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    10 High Street
    TW12 2SJ Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish629830001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Amministratore
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EXLEY, Richard John
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    British50191130002
    MCGARRITY, Stewart
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    British65801380001
    MONIZ, Christopher Mario
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritish3831690001
    PERRY, Albert Richard
    Gatcombe Chase Arrowsmith Road
    Canford Magna
    BH21 3BD Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    Gatcombe Chase Arrowsmith Road
    Canford Magna
    BH21 3BD Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish2012170001
    RYAN, Damien Michael
    Saintbury House
    Saintbury Avenue, Killiney Hill Road
    Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Saintbury House
    Saintbury Avenue, Killiney Hill Road
    Killiney
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish89077170002
    THOMPSON, Nathan James
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    Amministratore
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    British43320980004
    TRAUB, Stephen Eric Cameron
    Norwood Drive
    BT4 2EA Belfast
    22
    County Antrim
    United Kingdom
    Amministratore
    Norwood Drive
    BT4 2EA Belfast
    22
    County Antrim
    United Kingdom
    Northern IrelandBritish143642110001
    TUCKER, Louis Newton
    Bearehurst
    Holmwood
    RH5 4LR Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Bearehurst
    Holmwood
    RH5 4LR Dorking
    Surrey
    British37042480001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Amministratore
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003

    DENHAM PARK (UXBRIDGE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that property known as f/h areas of land adjoining oxford road uxbridge t/n NGL323390 and NGL52094 and the l/h land lying to the south of oxford road uxbridge t/n NGL340795. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moritz Holdings Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 giu 2005
    Consegnato il 21 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 21 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2005
    Consegnato il 21 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1,3 and 9 and car park spaces, highbridge industrial estate oxford road, uxbridge middlesex t/n NGL52094. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 21 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over shares
    Creato il 16 mar 2004
    Consegnato il 06 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from denham park limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all of the rights benefits powers privileges authorities discretions and remedies (in each case of any nature whatsoever) (rights) the title and interest in and to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 08 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from denham park limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease/s in respect of all that property k/a f/h areas of land adjoining oxford road uxbridge t/no's NGL323390 and NGL52094 and l/h land lying to the south of oxford road uxbridge t/no NGL340795, highbridge park oxford road uxbridge t/no AGL101319, for details of further properties/land charged please refer to the form 395 all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease/S. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from denham park limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that property k/a f/h areas of land adjoining oxford road uxbridge t/no's NGL323390 and NGL52094 and l/h land lying to the south of oxford road uxbridge t/no NGL340795 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over shares
    Creato il 08 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from denham park limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in the stocks shares in denbridge no 1 limited, denbridge no 2 limited, highbridge no 1 limited, highbridge no 2 limited, parkview no 1 limited and parkview no 2 limited and other securities of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 08 apr 2003
    Consegnato il 19 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from denham park limited and/or each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that property k/a f/h areas of land adjoining oxford road uxbridge t/no's NGL323390 and NGL52094 and the l/h land lying to the south of oxford road uxbridge t/no NGL340795 all rights title and interest in and to the policies the benefit of any covenants for title all rights and claims against all leases all rights title and interest in and to all contracts floating charge the undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moritz Holdings Limited
    Transazioni
    • 19 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of confirmation
    Creato il 25 mar 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Brevi particolari
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a oxford house and willowbank house t/n NGL320513. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1992
    Consegnato il 21 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 15.7.92
    Brevi particolari
    F/H land formerly K.A.97 oxford rd and unit 3 uxbridge (now K.A.willowbank house and oxford house).t/no.ngl 320513 with all fixtures,fittings. All rights.........benefit of all guarantees and other covenants........ See form 395.
    Persone aventi diritto
    • National Australia Bank Limited
    Transazioni
    • 21 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 gen 1988
    Consegnato il 26 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from property security investments trust PLC. To the chargee. Under the terms of a loan agreement dated 18 aug. 1983 and this charge.
    Brevi particolari
    F/H, unit 3, highbridge industrial estate, L.B. of hillingdon title no ngl 365400. (see form 395 and continuation sheets relevant to this charge).
    Persone aventi diritto
    • Bank of Montreal
    Transazioni
    • 26 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 1985
    Consegnato il 24 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18/6/85.
    Brevi particolari
    Fixed charge over oxford house and 97 oxford road and unit 3 uxbridge title no. Ngl 320513 and building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • First Interstate Bank of California
    Transazioni
    • 24 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 ott 1982
    Consegnato il 15 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14TH october 1982.
    Brevi particolari
    F/Hold units 4/4A & 5 highbridge industrial estate. Title no. Ngl 275549.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Grindlays Bank Limited.
    Transazioni
    • 15 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1979
    Consegnato il 05 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or property security investment trust limited to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H extension to unit 3, highbridge industrial estate, uxbridge, hillingdon. Ngl 320513.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Brown Shipley & Co. Limited.
    Transazioni
    • 05 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage dated 11TH nov 77
    Creato il 15 nov 1977
    Consegnato il 15 nov 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever advanced to property security investment trust limited.
    Brevi particolari
    124 & 125 high st uxbridge middlesex title no ngl 154638 97 high st uxbridge middlesex title nos. Ngl 152397 & mx 136957 unit 3 highbridge industrial estate uxbridge middx. Title nos. Ngl 52094 & mx 136957.
    Persone aventi diritto
    • Simmons & Simmons
    Transazioni
    • 15 nov 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 02 dic 1976
    Consegnato il 06 dic 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all moneys due from property security investment trust LTD, and louisville investments LTD to the chargee including the monies secured by a charge dated 7-8-64 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Property comprised in the principal deed and deeds supplemental thereto.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co. LTD.
    Transazioni
    • 06 dic 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1975
    Consegnato il 30 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £750,000 due from property security investment trust LTD
    Brevi particolari
    Unit 4, 4A and 5 highbridge industrial estate, uxbridge, middx.
    Persone aventi diritto
    • Unitholders Provident Assurance LTD.
    Transazioni
    • 30 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge
    Creato il 14 apr 1970
    Consegnato il 17 apr 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £180,000 and all other monies due or to become due from louisville investments LTD and property security investment trust LTD. To the chargee secured by two charges dated 7/8/64 and 24/8/66
    Brevi particolari
    Property comprised in a charge dated 7/9/67 and deeds supplemental thereto. (See doc 27 for details).
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurances Co. LTD.
    Transazioni
    • 17 apr 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental mortgage
    Creato il 30 gen 1970
    Consegnato il 06 feb 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £500,000 due from louisville investments limited secured by a charge dated 23/12/65
    Brevi particolari
    Industrial building known as unit no. 10 highbridge industrial estate, uxbridge.
    Persone aventi diritto
    • Friends Provident and Century Life Office
    Transazioni
    • 06 feb 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and further charge.
    Creato il 26 mar 1969
    Consegnato il 27 mar 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due from property security investment trust LTD. To chargee security a charge dated 24/8/66 and deeds supplemental thereto and all the monies due from louisville investments LTD to the chargee secured by a charge dated 7/8/64 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    F/Hold units 1, 3, 9 and car parking spaces at highbridge industrial estate, uxbrige, hillingdon title no. Mgl 52096. f/hold units 6A, 6B. 6C & 6D and car parking spaces at highbridge industrial estate, uxbridge, title no. Ngl 84659.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 27 mar 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 gen 1969
    Consegnato il 23 gen 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £500,000 with a premium payable in certain events due from louisville investments, LTD secured by a charge dated 23RD december, 1963.
    Brevi particolari
    Units nos. 7 & 8 highbridge industrial estate, uxbridge.
    Persone aventi diritto
    • Friends Provident and Century Life Office.
    Transazioni
    • 23 gen 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of substituted
    Creato il 04 set 1968
    Consegnato il 13 set 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Security effecting substitution of security for securing all monies due from louisville investments LTD. To the chargee secured by a charge dated 7TH august 1964 & deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    F/H units 6A, 6B, 6C, & 6D highbridge industrial estate, uxbridge, hillingdon & ancillery car parking spaces, being part of the land comprised title no. Mx 136957.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD.
    Transazioni
    • 13 set 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage & further charge
    Creato il 07 set 1967
    Consegnato il 27 set 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £410,000 inclusive of £250,000 and all other monies due etc from property security investment trust LTD to the chargee secured by two charges dated 24/8/66 & 24/11/66 respectively
    Brevi particolari
    Units 1, 3 and 9 highbridge industrial estate, uxbridge, middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD.
    Transazioni
    • 27 set 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0