ABSTRACT 123 LIMITED

ABSTRACT 123 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABSTRACT 123 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00886763
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABSTRACT 123 LIMITED?

    • (3210) /

    Dove si trova ABSTRACT 123 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    490-492 Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    Dorset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABSTRACT 123 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EMD DRIVE SYSTEMS LIMITED04 apr 200604 apr 2006
    THE ELECTRIC MOTOR COMPANY LIMITED07 ott 199907 ott 1999
    CETRONIC LIMITED31 ago 196631 ago 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABSTRACT 123 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ABSTRACT 123 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Justin Levine come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 feb 2011

    Stato del capitale al 01 feb 2011

    • Capitale: GBP 101,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 lug 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    21 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Justin Anthos Colin Levine il 12 feb 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Stephen Geoffrey Siggs come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter Dyoss come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine395

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di ABSTRACT 123 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SIGGS, Stephen Geoffrey
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    Segretario
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    148983680001
    SIGGS, Stephen Geoffrey
    Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    49
    Dorset
    Amministratore
    Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    49
    Dorset
    United KingdomBritish134418350001
    AMBROSE SMITH, Brian Aubrey
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Segretario
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    British569490001
    CARTER, Beryl Ann
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    British6279700001
    DYOSS, Peter James
    9 Harbour Watch
    391 Sandbanks Road
    BH14 8JB Poole
    Dorset
    Segretario
    9 Harbour Watch
    391 Sandbanks Road
    BH14 8JB Poole
    Dorset
    British105725380001
    MCDONALD, James
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    Segretario
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    British66970160001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Segretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    POTTER, Stephen Brian, Mr.
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    Segretario
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    English88179470001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    British118293300001
    SMITH, Simon John
    Church View 2-3 Stone Cottages
    Church Street, Great Maplestead
    CO9 2RG Halstead
    Essex
    Segretario
    Church View 2-3 Stone Cottages
    Church Street, Great Maplestead
    CO9 2RG Halstead
    Essex
    British70359030002
    WEARN, Roger Frederick
    Wyngar
    Stakes Hill Road
    PO7 5UB Waterlooville
    Hampshire
    Segretario
    Wyngar
    Stakes Hill Road
    PO7 5UB Waterlooville
    Hampshire
    British104899420001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    ALLEN, Gordon Stanley
    103 Valley Park Drive
    PO8 0PS Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    103 Valley Park Drive
    PO8 0PS Waterlooville
    Hampshire
    British67112500001
    AMBROSE SMITH, Brian Aubrey
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Amministratore
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    British569490001
    ASHBY, Simon Henry
    Coronation Cottage Main Road
    East Boldre
    SO42 7WU Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Coronation Cottage Main Road
    East Boldre
    SO42 7WU Brockenhurst
    Hampshire
    British41770060001
    BARBER, Julian Richard
    3 Mount Temple
    SO51 5UW Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    3 Mount Temple
    SO51 5UW Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish103374330003
    CARTER, David Patrick
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    British6279710001
    CURRY, John James
    Brett House 2 Mortlocks
    Lavenham
    CO10 9QF Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    Brett House 2 Mortlocks
    Lavenham
    CO10 9QF Sudbury
    Suffolk
    British49740520005
    FERRIER, Derek Neilson
    32 Melrose Road
    SO15 7PA Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    32 Melrose Road
    SO15 7PA Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish66914630002
    FISCHER, Andrew Olaf
    56 High Street
    St. Martins
    PE9 2LA Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    56 High Street
    St. Martins
    PE9 2LA Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomGerman70312740034
    FISHER, Ian
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Amministratore
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    United KingdomBritish51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    14 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    Amministratore
    14 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    United KingdomBritish14669590002
    HANSCOMBE, Peter Robert
    1 Oxford Road
    CO9 1AZ Halstead
    Essex
    Amministratore
    1 Oxford Road
    CO9 1AZ Halstead
    Essex
    British39413300001
    HARTLEY, Simon Andrew
    The Farmhouse
    Finchdean
    PO8 8AU Portsmouth
    Hants
    Amministratore
    The Farmhouse
    Finchdean
    PO8 8AU Portsmouth
    Hants
    British16818900001
    HIGGINSON, Andrew John
    Hawthorn House Long Road West Dedham
    CO7 6ES Colchester
    Essex
    Amministratore
    Hawthorn House Long Road West Dedham
    CO7 6ES Colchester
    Essex
    British74501390001
    HOWELL, Gregory
    242 Panfield Lane
    CM7 5RH Braintree
    Essex
    Amministratore
    242 Panfield Lane
    CM7 5RH Braintree
    Essex
    EnglandBritish101218720001
    LEVINE, Justin Anthos Colin
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    Amministratore
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    United KingdomBritish121019400003
    MCDONALD, James
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    British66970160001
    MONK, Brian
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    British19699310001
    OLIVER, David Anthony
    2 Kent Close
    Brightlingsea
    CO7 0PZ Colchester
    Essex
    Amministratore
    2 Kent Close
    Brightlingsea
    CO7 0PZ Colchester
    Essex
    British18752880001
    POTTER, Stephen Brian, Mr.
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    United KingdomEnglish88179470001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish118293300001
    ROBERTSON, Alan Charles
    Elmton House
    S80 4LX Elmton Creswell
    Near Worksop
    Amministratore
    Elmton House
    S80 4LX Elmton Creswell
    Near Worksop
    British95758980001
    RUSSELL, Jeremy
    132 Brunel Road
    SO15 0LR Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    132 Brunel Road
    SO15 0LR Southampton
    Hampshire
    British64515250003
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Amministratore
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritish6780200002

    ABSTRACT 123 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 apr 2000
    Consegnato il 02 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the security trustee and the secured beneficiaries (as defined) and to any of them under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 02 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 ott 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 03 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on west side of hoddesdon road st margarets stanstead abbotts ware hertfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 giu 1993
    Consegnato il 04 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1993
    Consegnato il 04 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The spinney hoddesdon road st margarets nr ware hertfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 set 1985
    Consegnato il 27 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge. Over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 nov 1982
    Consegnato il 29 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - unit 5D shefford industrial park, high STREET8 shefford, bedford.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 dic 1975
    Consegnato il 16 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property: office buildings, the spinney, hoddesdon road, st. Margarets, nr. Ware, hertfordshire, described in a convenience dated 1.12.75.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0