TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED

TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00890467
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    GAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2013

    5 pagineAA

    Stato del capitale al 30 apr 2014

    • Capitale: GBP 0.002
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2012

    5 pagineAA

    Nomina di Graham Middlemiss come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tom Brophy come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Graham Middlemiss come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 lug 2011

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Tom Brophy come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Alison Drew come segretario

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    30 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Stephen Webster come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert Andrew Ross Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MIDDLEMISS, Graham
    Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    20
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    20
    West Midlands
    United Kingdom
    174236780001
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Amministratore
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Amministratore
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director272310001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director272310001
    BROPHY, Tom
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    Segretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    162245940001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    Segretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    British86845230002
    OAKES, Antony Harry
    15 Redwood Drive
    PR7 3BW Chorley
    Lancashire
    Segretario
    15 Redwood Drive
    PR7 3BW Chorley
    Lancashire
    British81012890001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Segretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director272310001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    OAKES, Antony Harry
    15 Redwood Drive
    PR7 3BW Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    15 Redwood Drive
    PR7 3BW Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director81012890001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Amministratore
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    PERKINS, David Alan
    Filbert House 26 School Road
    Underwood
    NG16 5HB Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Filbert House 26 School Road
    Underwood
    NG16 5HB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director29390200001
    RICKARDS, Gerald
    428 Clifton Drive North
    FY8 2PW Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    428 Clifton Drive North
    FY8 2PW Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishCompany Director4773950001
    TILLOTSON, Ian
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    Amministratore
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director109050510001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    Amministratore
    Parkview 1220
    Arlington Business Park
    RG7 4GA Theale
    Reading
    United KingdomBritishCompany Director40201730005
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Amministratore
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishSolicitor82978250002

    TRENT COMBUSTION COMPONENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 dic 1988
    Consegnato il 06 dic 1988
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to kellock limited under the terms of an agreement dated 30/11/88
    Brevi particolari
    All the book debts and other debts due.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 06 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 21 set 1988
    Consegnato il 27 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or trent combustion energy products limited and/or trent energy & management systems limited to the chargee.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 27 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 giu 1988
    Consegnato il 21 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or trent combustion nergy products lt 17 and trent energy & management systems lt 17 to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 21 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1986
    Consegnato il 21 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings at gauntley street, basford, nottingham title no. Nt 41994.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Limited
    Transazioni
    • 21 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Aircraft mortgage deed
    Creato il 10 apr 1981
    Consegnato il 13 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £19,400
    Brevi particolari
    Aerospatialle tobago, british registered and marked gbiak and having serial number TB10/150 and engine serial number L28646/36/a.
    Persone aventi diritto
    • British Credit Trust Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 31 dic 1979
    Consegnato il 14 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage over property known as 50-72 gaunh ey st, nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 14 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 mar 1979
    Consegnato il 12 mar 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge upon the company's property known as 1240 sq.yds & thereabouts on western side of gaunhey street, nottingham. Fixed & floating charges over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transazioni
    • 12 mar 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 feb 1979
    Consegnato il 05 mar 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital (see doc M34).
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Limited
    Transazioni
    • 05 mar 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0