CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED

CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00892463
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED?

    • fabbricazione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (24100) / Industrie manifatturiere
    • fabbricazione di tubi, tubazioni, profili cavi e raccordi correlati in acciaio (24200) / Industrie manifatturiere
    • trafilatura a freddo di fili (24340) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Floor 8 Central Square
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAPARO TUBES LIMITED27 gen 199427 gen 1994
    NATURAL GAS TUBES LIMITED22 nov 196622 nov 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2023

    25 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2022

    25 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Secretary of state's release of liquidator.
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    15 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    13 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2021

    25 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    17 pagineLIQ10

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2019

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2018

    28 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 More London Riverside London SE1 2RT a Floor 8 Central Square Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL in data 06 ott 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    32 pagineAM22

    Dimissioni di un amministratore

    11 pagine2.38B

    Nomina di un amministratore

    pagine2.12B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 ott 2016

    27 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 apr 2016

    31 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Derek Michael O'reilly come amministratore in data 17 dic 2015

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Caparo Steel Products Ltd 103 Baker Street London W1U 6LN a 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 12 gen 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    18 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Chi sono gli amministratori di CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Amministratore
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited KingdomDirector130813310001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    British126516810001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Segretario
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director10618480001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Segretario
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British10618480001
    WILKINSON, John Terence
    Oxmoor House
    The Narth
    NP5 4QG Monmouth
    Gwent
    Segretario
    Oxmoor House
    The Narth
    NP5 4QG Monmouth
    Gwent
    BritishFinancial Director74980580001
    BENBOW, Martin
    59 Park Road
    Hagley
    DY9 0QQ Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    59 Park Road
    Hagley
    DY9 0QQ Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector109354670001
    CHARMAN, Adrian
    Caparo Steel Products Ltd
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo Steel Products Ltd
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector139910370002
    DIMMOCK, Geoffrey Hugh
    10 Hobart Close
    NP9 3QR Newport
    Gwent
    Amministratore
    10 Hobart Close
    NP9 3QR Newport
    Gwent
    BritishDirector28831030002
    DIMMOCK, Geoffrey Hugh
    10 Hobart Close
    NP9 3QR Newport
    Gwent
    Amministratore
    10 Hobart Close
    NP9 3QR Newport
    Gwent
    BritishOperations Director28831030002
    EMMENEGGER JNR, Charles E
    715 Rietzke Mtn Trail
    Ballwin Mo 63021
    America
    Amministratore
    715 Rietzke Mtn Trail
    Ballwin Mo 63021
    America
    AmericanDirector37965200002
    HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    BritishDirector12310490001
    HICKMAN, Roger Geoffrey
    Rosebine House
    Eyton
    LL13 0SN Wrexham
    Amministratore
    Rosebine House
    Eyton
    LL13 0SN Wrexham
    BritishDirector45598510002
    JARVIS, Andrew Laurence
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    Amministratore
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    United KingdomBritishManaging Director93158620001
    JARVIS, Andrew Laurence
    19 Lancaster Way
    Osbaston
    NP5 4DA Monmouth
    Monmouthshire
    Amministratore
    19 Lancaster Way
    Osbaston
    NP5 4DA Monmouth
    Monmouthshire
    BritishOperations Director57600580001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Amministratore
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    BritishDirector11293430001
    LORMOR, Paul Frederick
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    BritishChief Executive30814040001
    MORLEY, Richard
    35 Lockwood Bank
    Epworth
    DN9 1JH Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    35 Lockwood Bank
    Epworth
    DN9 1JH Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director36139100003
    MORRILL, Dennis
    17 Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    17 Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritishManaging Director37889640001
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritishDirector178034370001
    PAUL, Akhil
    Caparo Steel Products Ltd
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo Steel Products Ltd
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritishDirector147065830001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritishCo.Director92729600003
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector92729600003
    PAUL OF MARYLEBONE, The Lord
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Amministratore
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    EnglandBritishDirector11293420003
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishDirector126516810001
    PEARSON, Byron
    40 Ridgeway Moor
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    40 Ridgeway Moor
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director22534130001
    RIX, Jonathan David
    19 Delafield Road
    NP7 7AW Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    19 Delafield Road
    NP7 7AW Abergavenny
    Gwent
    BritishSales Director28831050001
    SHAW, Christopher Norman
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    Amministratore
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    United KingdomBritishDirector28831060001
    STATHAM, Mark
    212 Lichfield Road
    Little Bloxwich
    WS3 3DF Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    212 Lichfield Road
    Little Bloxwich
    WS3 3DF Walsall
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector42142340001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector10618480001
    WILKINSON, John Terence
    Oxmoor House
    The Narth
    NP5 4QG Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Oxmoor House
    The Narth
    NP5 4QG Monmouth
    Gwent
    BritishDirector74980580001
    WOOD, John Franklin
    Caparo Steel Products Ltd
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo Steel Products Ltd
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector1397720001
    WRAITH, John Albert Henry
    Statner Hill Cottage
    Messingham
    DN17 3PA Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Amministratore
    Statner Hill Cottage
    Messingham
    DN17 3PA Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director93158850001

    CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 15 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H real estate:. Caparo wire, ash road south, wrexham t/no's WA763387 and WA877754. Caparo wire, ash road north, wrexham t/no WA552047. Caparo tubes, tafarnaubach industrial estate, tredegar t/no WA442551. (For further details of properties charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Transazioni
    • 15 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 05 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land k/a caparo wire ash road south wrexham t/nos WA763387 and WA877754. F/h land k/a caparo wire ash road north wrexham t/no WA552047. F/h land k/a caparo tubes tafanaubach industrial estate tredegar t/no WA442551. For details of further intellectual property please refer to the deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Security agreement
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Creato il 31 gen 2002
    Consegnato il 14 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) fixed equitable charge any debt (as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which vail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 11 lug 1989
    Consegnato il 21 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Land & buildings on the tafarnaubach industrial est, tredegor gwent. K/as the former apg building.
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 21 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 feb 1989
    Consegnato il 21 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plant machinery & office equipment & other fittings of the former apb building (see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 21 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 1984
    Consegnato il 11 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge incorporating a fixed charge & over book debts.
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 11 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 feb 1980
    Consegnato il 13 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £645,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 5 february 1980
    Brevi particolari
    Plot 3 tajarnanbach insustrial estate ebbw vale, gwent.
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 13 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 giu 1979
    Consegnato il 11 giu 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due under the terms of the dollar loan agreement dated 23 rd march 1976 and agreements supplemental thereto and the offer letter dated 25TH april 1977 & agreements supplemental thereto
    Brevi particolari
    Plot 3, tajamanbach industrial estate, ebbw vale, gwent.
    Persone aventi diritto
    • Swiss/Bank Corporation
    Transazioni
    • 11 giu 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 giu 1977
    Consegnato il 16 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 23TH march 1976 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    P r d swp 2 40" spinal weld pipe mill together with ancillery tooling cixtures and testing and facing machinery (see DOCM30).
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 16 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAPARO STEEL PRODUCTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 ott 2015Inizio dell'amministrazione
    25 apr 2017Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Ross David Connock
    2 Glass Wharf
    BS2 0EL Bristol
    Avon
    Praticante
    2 Glass Wharf
    BS2 0EL Bristol
    Avon
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    2
    DataTipo
    05 dic 2023Data prevista di scioglimento
    25 apr 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Edward Williams
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0