EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED

EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00892891
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STAVORDALE GARAGES LIMITED28 nov 196628 nov 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 21 mar 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard James Maloney come segretario in data 01 gen 2017

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2016

    Stato del capitale al 10 giu 2016

    • Capitale: GBP 5,060
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 26 ott 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2015

    Stato del capitale al 12 giu 2015

    • Capitale: GBP 5,060
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2014

    Stato del capitale al 16 giu 2014

    • Capitale: GBP 5,060
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    222173920001
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    EVANS HALSHAW MOTORS LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2304195
    38967740005
    PITT, Andrew Joseph
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    Segretario
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    British10739800001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    ARCHER, Anthony Bernard
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    Amministratore
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    British46351440001
    DALE, Arthur Geoffrey
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    British10739820001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41559790001
    VAN DE BROEK, Jeffrey
    Brasenose
    Kemerton
    GL20 7HR Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brasenose
    Kemerton
    GL20 7HR Tewkesbury
    Gloucestershire
    British35967480001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Evans Halshaw Motor Holdings Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione1212182
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EVANS HALSHAW (THE WIRRAL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    General charge.
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 01 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the charges porperty whatsoever (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 01 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge stock
    Creato il 10 ago 1988
    Consegnato il 17 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stock in trade motor vehicles.
    Persone aventi diritto
    • N W S Trust LTD.
    Transazioni
    • 17 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 21 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land & buildings k/a 3 stavordale road. Moreton wallasey wirral merseyside title no ch 58840. fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 21 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 mar 1986
    Consegnato il 07 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M31. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 07 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 29 ott 1984
    Consegnato il 14 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 30 mar 1983
    Consegnato il 13 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h properties present and future with fixtures (inc trade fixtures) fixed plant and machinery, goodwill and uncalled capital present and future. Undertaking and all other property and assets present and future, including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charge (see doc M27).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 apr 1981
    Consegnato il 14 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over goodwill & book debts together with all fixtures plant & machinery (see doc M26).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1980
    Consegnato il 19 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 haylake road, moreton, wirral merseyside comprised in a transfer dated 22-11-79.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0