NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00893718 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
- Installazione elettrica (43210) / Costruzioni
- Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni
Dove si trova NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O BISHOP FLEMING LLP 10 Temple Back BS1 6FL Bristol Avon |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SUPERIOR PLUMBING INSTALLATIONS LIMITED | 08 dic 1966 | 08 dic 1966 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason Andrew Scagell come amministratore in data 30 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Deborah Gandley come amministratore in data 13 giu 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Glenn William Chapman come segretario in data 01 apr 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Nicholas Stacey come amministratore in data 02 gen 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Windmill Hill Business Park Whitehill Way Swindon Wiltshire SN5 6PB a 10 Temple Back Bristol Avon BS1 6FL in data 17 dic 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Notifica di Npower Group Limited come persona con controllo significativo il 29 ott 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Npower Northern Limited come persona con controllo significativo il 29 ott 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Nichola Handley come amministratore in data 28 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jason Andrew Scagell come amministratore in data 29 mag 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Nicholas Stacey il 01 feb 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Trevor David Yeoman come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Nichola Handley come amministratore in data 01 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Nicholas Stacey come amministratore in data 01 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James William Mccarthy come amministratore in data 31 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 dic 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANDLEY, Deborah | Amministratore | Temple Back BS1 6FL Bristol 10 Avon | England | British | 96891580001 | |||||
| CHAPMAN, Glenn William | Segretario | Temple Back BS1 6FL Bristol 10 Avon | 222212160001 | |||||||
| COOKE, Barry | Segretario | 3 Broome Close Kings Bromley DE13 7JR Burton On Trent Staffordshire | British | 99040510001 | ||||||
| DILLION, Paul | Segretario | Belmont Cottage Bar Lane Barton Under Needwood DE13 8AL Burton On Trent Staffordshire | British | 117563320001 | ||||||
| DILLON, Patricia Anne | Segretario | 15 Gisborne Close Yoxall DE13 8NU Burton On Trent Staffordshire | British | 21022880001 | ||||||
| KANE, Michael Geoffrey | Segretario | Falstaff Close Walmley B76 1YG Sutton Coldfield 31 | British | 132665580001 | ||||||
| KEENE, Jason Anthony | Segretario | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | British | 37516950002 | ||||||
| SEDDON, Nigel Ralph | Segretario | Shandon Lodge 14 Tarvin Road Littleton CH3 7DG Chester Cheshire | British | 119519570001 | ||||||
| CLARK, Jason Lee | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | British | 160071400001 | |||||
| COOKE, Barry | Amministratore | Broome Manor 5 Broome Close Kings Bromley DE13 7JR Burton On Trent Staffordshire | British | 11810310003 | ||||||
| DILLON, John William | Amministratore | Gorsey Hill Farm Bar Lane, Barton Under Needwood DE13 8AJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 141798580001 | |||||
| DILLON, John Edward | Amministratore | 15 Gisborne Close Yoxall DE13 8NU Burton On Trent Staffordshire | England | British | 21022890001 | |||||
| DILLON, Mark John | Amministratore | 14 Hereford Way Fazeley B78 3XT Tamworth Staffordshire | British | 40304060004 | ||||||
| DILLON, Patricia Anne | Amministratore | 15 Gisborne Close Yoxall DE13 8NU Burton On Trent Staffordshire | England | British | 21022880001 | |||||
| DILLON, Paul John | Amministratore | Shaw Lane Bromley Hayes WS13 8HN Nr Lichfield Shaw Barn Farm Staffs | United Kingdom | British | 141798590001 | |||||
| EATON, Jodie | Amministratore | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | United Kingdom | British | 174710500001 | |||||
| FERRIDAY, Roger Frederick | Amministratore | 1 Oregan Gardens Chase Terrace WS7 8BB Burntwood Staffordshire | British | 1774880003 | ||||||
| HANDLEY, Nichola | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 278921930001 | |||||
| HUXLEY, Stephen George | Amministratore | Manor Farm House 33 High Street Ketton PE9 3TA Stamford Lincolnshire | England | British | 96882500001 | |||||
| JEMMETT, Richard William | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 68677410002 | |||||
| KANE, Michael Geoffrey | Amministratore | Falstaff Close Walmley B76 1YG Sutton Coldfield 31 | British | 132665580001 | ||||||
| LEWIS, David Peter | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 171297500001 | |||||
| LYNCH-WILLIAMS, Julia | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 151681150001 | |||||
| MASSARA, Paul Joseph | Amministratore | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | England | British | 164191880001 | |||||
| MCCARTHY, James William | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 189001680002 | |||||
| MILES, Kevin | Amministratore | Oak House Bridgwater Road WR4 9FP Worcester | England | British | 118618160001 | |||||
| PEARCE, Andrew John | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 178946580001 | |||||
| ROSE, Richard Lee | Amministratore | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | United Kingdom | British | 254428960001 | |||||
| SCAGELL, Jason Andrew | Amministratore | Temple Back BS1 6FL Bristol 10 Avon | England | British | 177545430002 | |||||
| SEDDON, Nigel Ralph | Amministratore | Shandon Lodge 14 Tarvin Road Littleton CH3 7DG Chester Cheshire | United Kingdom | British | 119519570001 | |||||
| SHEARS, Kim Toney | Amministratore | 16 Peel Close Drayton Bassett B78 3UE Tamworth Staffordshire | England | British | 56312710001 | |||||
| SLADE, Anthony John | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | United Kingdom | British | 198209140001 | |||||
| SPENCER, Richard Jonathan | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire | England | British | 189001690001 | |||||
| STACEY, Simon Nicholas | Amministratore | Temple Back BS1 6FL Bristol 10 Avon | England | British | 235361480001 | |||||
| STACEY, Simon Nicholas | Amministratore | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | British | 235361480001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Npower Group Limited | 29 ott 2021 | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Npower Northern Limited | 06 apr 2016 | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 01 giu 2007 Consegnato il 20 giu 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £2780.83 and all sums that may be paid under the terms of the rent deposit deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 01 dic 2006 Consegnato il 15 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All properties and property interests equipment securities and securities system rights intellectual property insurance policies and debts accounts pension fund interests goodwill and uncalled capital and other rights floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 01 dic 2006 Consegnato il 07 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from or by any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 28 ott 2003 Consegnato il 04 nov 2003 | In corso | Importo garantito £7,475.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 10 nov 1989 Consegnato il 20 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 9 high street, chasetown, near walsall, west midlands by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 28 gen 1985 Consegnato il 31 gen 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 25 ott 1971 Consegnato il 01 nov 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 7 high st chasetown staffs. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
NPOWER BUSINESS AND SOCIAL HOUSING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0