BRIGHTSEA FREL LIMITED

BRIGHTSEA FREL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRIGHTSEA FREL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00897846
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    F.R.EVANS(LEEDS)LIMITED09 feb 196709 feb 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2013

    Stato del capitale al 03 set 2013

    • Capitale: GBP 50,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2011

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2010

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    16 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    6 pagine395

    Chi sono gli amministratori di BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135442170001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    BOTTOMLEY, Simon David
    Fountain House The Walled Garden
    Woolley
    WF4 2JW Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fountain House The Walled Garden
    Woolley
    WF4 2JW Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish66174770001
    CROFT, Simon John
    100 Hall Lane
    Horsforth
    LS18 5JG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    100 Hall Lane
    Horsforth
    LS18 5JG Leeds
    West Yorkshire
    British63472210001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Amministratore
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    GOODWILL, Geoffrey Mortimer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100020003
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HOLLEY, Peter Ian
    1 Coniston Way
    Woodlesford
    LS26 8RR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Coniston Way
    Woodlesford
    LS26 8RR Leeds
    West Yorkshire
    British62699010001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Amministratore
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Amministratore
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    PRINGLE, David Anthony
    Sandal Parkside
    BD16 4AD Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sandal Parkside
    BD16 4AD Bingley
    West Yorkshire
    British52239350001
    SYERS, Aian Matthew
    No1 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO2 3TB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    No1 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO2 3TB York
    North Yorkshire
    British65588650001
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    BRIGHTSEA FREL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Tenth supplemental trust deed
    Creato il 24 dic 2008
    Consegnato il 07 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a derwenthaugh industrial estate, gateshead t/no TY388552. F/h property k/a viceroy works, leeds on the north east side of low fields road t/no WYK450296 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 24 dic 2008
    Consegnato il 07 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Derwenthaugh industrial estate, gateshead t/no TY388552 and viceroy works, leeds t/no WYK450296 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transazioni
    • 07 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 26 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transazioni
    • 26 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal mortgage
    Creato il 23 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at lancaster park, audax close, clifton moor, york t/n NYK246758 including buildings fixtures and fittings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 feb 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a land at canon house apex way leeds t/n WYK307583 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 feb 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a land at hume house wade lane leeds t/n WYK192637 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 31 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings to the east side of dewsbury road and south side of parkfield street leeds t/nos WYK261704 and WYK123533 the fixtures and fittings the plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 31 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings to the north east of armley road leeds t/n WYK421254 and WYK421255, fixtures and fittings, plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Seventh supplemental trust deed
    Creato il 21 ott 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a deeside industrial estate,deeside.t/nos WA864223 and CYM166484.all that f/h property k/a redvers house,sheffield.t/n SYK325658.all that f/h property k/a firth court,leeds.t/n WYK561178.(for details of further properties charged please see form 395) together with all buildings,erections and fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Sixth supplemental trust deed
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 01 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a single warehouse unit with ancillary offices at old run road, hunslet t/no WYK653056 and moor road, hunslet t/no WYK547405 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transazioni
    • 01 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 18 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a springhead mill, well lane, guiseley, leeds t/no. WYK436492; and f/h land k/a swinderby industrial park, camp road, st hughes, newark t/nos. LL140686 and LL238817 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 18 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) f/hold land on north west side of george st,york,north yorkshire; NYK81755; (ii) l/hold land on north west side of kenyon rd,lomeshaye industrial estate,nelson,lancashire; LA565287; (iii) part of f/hold land on the south west side of audax rd,clifton moor,york,north yorkshire; NYK246758; all buildings and fixtures thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fourth supplemental trust deed made between evans of leeds limited (1) f r evans (leeds) limited (2) mulgate investments limited (3) fradley park limited (4) evans homes limited (5) and the law debenture trust corporation P.L.C.(6)
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land at dearne mills, darton, barnsley t/n SYK388051, land at springhead mills, well lane, guiseley t/n WYK436492, land at 22-30 new york street and 13-15 harper street, leeds, t/n WYK541898, and land at former leodis works, north west road, leeds, t/ns WYK346534 and YWE69198, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and the benefit of the existing leases, underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants and conditions;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 14 mar 2003
    Consegnato il 25 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage l/h land being redvers house furnival street sheffield south yorkshire t/no SYK325658.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 25 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mar 2003
    Consegnato il 15 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a mickelthwaite farm boston road wetherby t/n YWE34743 and WE4209.
    Persone aventi diritto
    • Crosby Homes (Yorkshire) Limited
    Transazioni
    • 15 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental mortgage
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 17 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Freehold property capitol house, 10, 12 and 14 infirmary street and 31/33 east parade, leeds, west yorkshire t/n's WYK176561, WYK515923 and WYK625100 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant and machinery and equipment for the time being thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from incumbrances.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 17 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 19 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee all the estate and interests of the company in the land together with all buildings and fixtures at any time thereon. F/h land k/a 22-30 (even) new york street and 13 and 15 harper street leeds t/n WYK541898, f/h land k/a 10 manor street leeds t/n WYK529539, f/h land k/a land on the west side of millshaw beeston leeds t/n WYK488274 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 19 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold land known as apex park, dewsbury road, leeds, t/nos. WYK261704, WYK123533 and WYK185000. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold land known as land and buildings to the north east of armley road, leeds (also known as albion park) t/no. WYK421255. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold land and buildings at burley road, leeds t/no. WYK522897 and the leasehold land known as land and buildings at burley road, leeds t/no. WYK522840 and the freehold land known as land on the east side of skippers lane, south bank middlesborough t/nos. CE123760, CE134943, CE132407 and CE134946 for details of further properties charged please see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 01 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH spetember 1995 and deeds (all as defined in the deed of release and substitution and defined on the form 395) all of which are supplemental to the trust deed dated 20TH september 1985
    Brevi particolari
    Land on the south side of audax road clifton moor york t/n-NYK246758 and land on the south east of mill lane t/n-WYK208617 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 01 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 20 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (or any of them) and/or on any other account whatsoever (all terms as defined)
    Brevi particolari
    F/H land on the south west side of audax road clifton moor north yorkshire t/n NYK179182 and land and buildings at dean terrace ryton gateshead tyne and wear t/n TY166262. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself Andthe Beneficiaries
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and deposit
    Creato il 18 gen 2000
    Consegnato il 20 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    £850,000.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 20 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Deed of release and deposit
    Creato il 07 gen 2000
    Consegnato il 19 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    £572,500 due or to become due from the company to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 19 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Deed of release and deposit
    Creato il 04 gen 2000
    Consegnato il 11 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds dated 7 april 1988, 1 february 1989, 29 march 1989, 4 december 1992, 23 december 1992, 4 november 1993, 29 september 1994, 17 november 1994, 12 july 1995, 26 september 1995, 20 september 1996, 14 march 1997, 16 july 1997, 18 september 1997, 25 june 1998, 30 october 1998, 30 april 1999, 4 june 1999, 28 june 1999, 30 june 1999, 6 august 1999, 1 october 1999, 7 october 1999, 14 october 1999, 5 november 1999 and 4 january 2000 all of which are supplemental to the trust deed dated 20 september 1985
    Brevi particolari
    £1,165,000.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0