VICTORIA CASINO LIMITED

VICTORIA CASINO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVICTORIA CASINO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00898336
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VICTORIA CASINO LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VICTORIA CASINO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VICTORIA CASINO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VICTORIA CASINO LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VICTORIA CASINO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Poynt 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW* in data 07 lug 2014

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England* in data 10 mar 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 29/01/2014
    RES13

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    3 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    33 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Re-transitional provisions & savings 20/08/2013
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Willits il 19 feb 2013

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 71 Queensway London W2 4QH England* in data 15 feb 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2010

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Diane Penfold come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Harry Willits come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di VICTORIA CASINO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Segretario
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3720332
    154706290001
    BOTTERILL, Sheila Mary
    1 Appledore Close
    Kingsthorpe
    NN2 8JG Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    1 Appledore Close
    Kingsthorpe
    NN2 8JG Northampton
    Northamptonshire
    British11261450001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    British66090970001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Segretario
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MILLER, John Ashley Laing
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British97666900001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Segretario
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    York House 14 Ashton Place
    SL6 4TA Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    York House 14 Ashton Place
    SL6 4TA Maidenhead
    Berkshire
    British52292450002
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Amministratore
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Amministratore
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DAVIS, Leonard Lewis
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomEnglish19157470001
    DAVIS, Leonard Lewis
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomEnglish19157470001
    DAVIS, Sarah Luise
    64 Wrentham Avenue
    Kensal Rise
    NW10 3HG London
    Amministratore
    64 Wrentham Avenue
    Kensal Rise
    NW10 3HG London
    British56962430002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Amministratore
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Amministratore
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Amministratore
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Amministratore
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British39465560001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SHINE, David
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    Amministratore
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    British8824890001
    SHINE, David
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    Amministratore
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    British8824890001
    SHINE, Martyn
    The Grange Kennel Terrace
    Brixworth
    NN6 9DL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Grange Kennel Terrace
    Brixworth
    NN6 9DL Northampton
    Northamptonshire
    British78895540001
    SHINE, Martyn
    40 Wildern Lane
    East Hunsbury
    NN4 0SN Northampton
    Amministratore
    40 Wildern Lane
    East Hunsbury
    NN4 0SN Northampton
    British78895540002
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001

    VICTORIA CASINO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 24 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 24 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 20 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 18 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 18 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 17 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) regent st,northampton NN1 2LA; NN44035; (ii) 21 thornley st,wolverhampton WV1 1JR; WM271335; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 11 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Brevi particolari
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transazioni
    • 11 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    Floating charge over all. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for Itself and for the Banks (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    Floating charge over all. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Stakis PLC
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 set 1992
    Consegnato il 21 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc ref M478C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 giu 1990
    Consegnato il 14 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the west side of regent square northampton northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1990
    Consegnato il 11 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    116 ashburnham road northampton.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1988
    Consegnato il 09 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    51 south holme court, thorplands, northampton title no. NN67378.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 06 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a no 1 summerfield road, chapel ash, wolverhampton west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 1987
    Consegnato il 02 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rubicon casi no 22 22 regent street northampton, northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1983
    Consegnato il 04 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 'layayette club' 21 thornley street wolverhampton west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VICTORIA CASINO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 ott 2014Data di scioglimento
    27 feb 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jill Sandford
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Patrick B Ellward
    The Poynt
    45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praticante
    The Poynt
    45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0