TDL 2013 REALISATIONS LIMITED

TDL 2013 REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTDL 2013 REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00902438
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    • Altre attività di editoria (58190) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THOMSON DIRECTORIES LIMITED06 mag 199406 mag 1994
    T.I.S. (DIRECTORIES) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    DIRAG LIMITED31 mar 196731 mar 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2012
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2013
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al07 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma21 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 mag 2016

    11 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    7 pagineF10.2

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    19 pagine2.23B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 gen 2015

    19 pagine2.24B

    Avviso di decadenza dall'incarico da parte dell'amministratore

    13 pagine2.39B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 lug 2014

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 feb 2014

    18 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    10 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    46 pagine2.17B

    Avviso di ordine per trattare con la proprietà gravata

    6 pagine2.28B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed thomson directories LIMITED\certificate issued on 21/08/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name21 ago 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 ago 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da , Thomson House, 296 Farnborough Road, Farnborough, Hants, GU14 7NU in data 20 ago 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Nomina di Mr Vincenzo Santelia come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stefano Collmann come amministratore

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    59 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRISTOFORI, Massimo
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    Amministratore
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    ItalyItalian132342550001
    GIURI, Paolo
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    Amministratore
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    FranceItalian168980660001
    SAHGAL, Gautam Giorgio
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    Amministratore
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    EnglandItalian137239430002
    SANTELIA, Vincenzo
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    Amministratore
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    ItalyItalian175089960001
    SCHIAVO, Elio
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    Amministratore
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Lancashire
    United KingdomItalian146826620002
    CARUANA, Geraldine Bridget
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    Segretario
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    British66575160003
    DEALTRY, Charles Mark
    Woodbury House Churt Road
    GU10 2NY Churt
    Surrey
    Segretario
    Woodbury House Churt Road
    GU10 2NY Churt
    Surrey
    British53530940001
    HUDSON, John Garland
    23 Copse Avenue
    Weybourne
    GU9 9ED Farnham
    Surrey
    Segretario
    23 Copse Avenue
    Weybourne
    GU9 9ED Farnham
    Surrey
    British17864590001
    MITCHELL, Gordon Philip
    2 Greystead Park
    Wrecclesham
    GU10 4NB Farnham
    Surrey
    Segretario
    2 Greystead Park
    Wrecclesham
    GU10 4NB Farnham
    Surrey
    British62974200001
    RUSSELL, Angela
    75 Ondine Road
    SE15 4EA London
    Segretario
    75 Ondine Road
    SE15 4EA London
    British776080001
    WATSON, Kevin John
    Chalk House
    Dunkirt Lane Abbotts Ann
    SP11 7BB Andover
    Hampshire
    Segretario
    Chalk House
    Dunkirt Lane Abbotts Ann
    SP11 7BB Andover
    Hampshire
    British62572410001
    ALEXANDER WALL, Michael Graeme
    77 Tavistock Road
    W11 London
    Amministratore
    77 Tavistock Road
    W11 London
    British111709200001
    BOSWELL, Ralph Henry
    95 Garner Road
    E17 4HG London
    Amministratore
    95 Garner Road
    E17 4HG London
    British2741160001
    BRUNI, Gian Luca
    Leone Pancaldo 98 App 18
    FOREIGN Verona
    37138
    Italy
    Amministratore
    Leone Pancaldo 98 App 18
    FOREIGN Verona
    37138
    Italy
    Italian86405510001
    CAPPELLINI, Alberto
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    Amministratore
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    ItalyItalian139246330001
    CASASSA, Giacomo
    Via Cardinal M Fossati
    Turin
    2-10100
    Italy
    Amministratore
    Via Cardinal M Fossati
    Turin
    2-10100
    Italy
    Italian111464390001
    COLLMANN, Stefano
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    Amministratore
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    ItalyItalian126673700001
    DEALTRY, Charles Mark
    Woodbury House Churt Road
    GU10 2NY Churt
    Surrey
    Amministratore
    Woodbury House Churt Road
    GU10 2NY Churt
    Surrey
    British53530940001
    GARTLAND, William Joseph
    Abbots Wood Burwood Park
    1 Broadwater Road
    KT12 5DB Walton-On-Thames
    Surrey
    Amministratore
    Abbots Wood Burwood Park
    1 Broadwater Road
    KT12 5DB Walton-On-Thames
    Surrey
    American30389460001
    GILL, John Anthony Samuel
    Brae Rise Berry Lane
    Worplesdon
    GU3 3QF Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Brae Rise Berry Lane
    Worplesdon
    GU3 3QF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish13490001
    GIURI, Paolo
    Via G Medici 26
    Turin
    Italy
    Amministratore
    Via G Medici 26
    Turin
    Italy
    Italian81983600001
    GOLDSMITH, Michael John
    12 Elainor Road
    CO3 3RX Colchester
    Essex
    Amministratore
    12 Elainor Road
    CO3 3RX Colchester
    Essex
    British2910860001
    GRAS, Robert William
    3 Cheyne House
    18 Chelsea Embankment
    SW3 4LA London
    Amministratore
    3 Cheyne House
    18 Chelsea Embankment
    SW3 4LA London
    Us Citizen47389780001
    HOLT, Penelope Jane
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    Amministratore
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    United KingdomBritish159792430002
    HOPSON, Andrew James
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    Amministratore
    Thomson House
    296 Farnborough Road
    GU14 7NU Farnborough
    Hants
    United KingdomBritish81235030001
    HUDSON, John Garland
    23 Copse Avenue
    Weybourne
    GU9 9ED Farnham
    Surrey
    Amministratore
    23 Copse Avenue
    Weybourne
    GU9 9ED Farnham
    Surrey
    British17864590001
    KEMP, John Harvey
    Creekside 20 Derwent Close
    GU9 0DD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Creekside 20 Derwent Close
    GU9 0DD Farnham
    Surrey
    British70382690001
    KIERNAN, Robert
    Westwood
    Burnt Oak Lane Waldron
    TN21 0NY Heathfield
    Sussex
    Amministratore
    Westwood
    Burnt Oak Lane Waldron
    TN21 0NY Heathfield
    Sussex
    British82170680001
    KNIGHT, Mark David
    The Old Rectory
    Ightham
    TN15 9AJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Old Rectory
    Ightham
    TN15 9AJ Sevenoaks
    Kent
    GbrBritish58674470001
    LIST, Gary Chuckna
    Glenbrook Cavendish Road
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Glenbrook Cavendish Road
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    United StatesBritish,American40383190004
    MAJOCCHI, Luca
    Via Degli Alberoni 13/A
    Turin
    Italy
    Amministratore
    Via Degli Alberoni 13/A
    Turin
    Italy
    Italian112758600001
    MAURI, Ernesto Riccardo
    Via Pietro Mascagni , 20
    Milan
    FOREIGN 20122
    Italy
    Amministratore
    Via Pietro Mascagni , 20
    Milan
    FOREIGN 20122
    Italy
    Italian89646490001
    MITCHELL, Gordon Philip
    2 Greystead Park
    Wrecclesham
    GU10 4NB Farnham
    Surrey
    Amministratore
    2 Greystead Park
    Wrecclesham
    GU10 4NB Farnham
    Surrey
    British62974200001
    NIGRI, Francesco
    V.G. Casalis N 28
    Turin
    10143
    Italy
    Amministratore
    V.G. Casalis N 28
    Turin
    10143
    Italy
    Italian81982440001
    PANCRATZ, Linda
    Connaught Four Winds Park
    Old Avenue St Georges Hill
    KT13 0QA Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Connaught Four Winds Park
    Old Avenue St Georges Hill
    KT13 0QA Weybridge
    Surrey
    American53260870001

    TDL 2013 REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 06 set 2012
    Consegnato il 13 set 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secred parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land being thomson house farnborough road barnborough t/no HP360228 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 06 set 2012
    Consegnato il 13 set 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2010
    Consegnato il 09 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 mar 2009
    Consegnato il 31 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    £6,325.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £6,325.00 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gle Properties Limited
    Transazioni
    • 31 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 giu 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the comapnty to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Milan Branch)
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 gen 2005
    Consegnato il 21 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Senior Security Agent)
    Transazioni
    • 21 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 lug 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from such charging company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and all monies and liabilities due or to become due from each other company to the chargee and to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floor premises runnymede house hawthorne road staines; third floor premises 1 bridewell street bristol; ground floor unit 9 castleton court st mellons cardiff. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 04 giu 1997
    Consegnato il 17 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or hopenice limited (now known as tdl group limited) and/or any other group company (as defined therein) to the chargee under the terms of the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed charges over all f/h and l/h property present and future all proceeds of sale thereof, benefit of all licences,all plant and macinery and all rights thereof, all rental monies,all securities, all contracts and policies all goodwill and uncalled capital all intellectual property rights all book and other debts proceeds of all recievables together with floating charge all assets not charged by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries (as Defined Therein))
    Transazioni
    • 17 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 set 1987
    Consegnato il 21 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all moneys due & to become due from the company and/or dennelly directory limited to the chargee under the terms of a lease dated 28TH nov 86.
    Brevi particolari
    The sums of £14,250 & such greater sum as shall from time to time be equal to six months rent payable under the lease.
    Persone aventi diritto
    • Peachey Property Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 set 1987Registrazione di un'ipoteca

    TDL 2013 REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 ago 2013Inizio dell'amministrazione
    19 mag 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    19 mag 2015Inizio della liquidazione
    21 feb 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Dunckley
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Liquidatore proposto
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0