WHOLE EARTH FOODS LIMITED

WHOLE EARTH FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHOLE EARTH FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00906935
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (46390) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KALLO FOODS LTD
    River View 2 The Meadows Business Park
    Blackwater,
    GU17 9AB Camberley
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARMONY FOODS LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    YIN-YANG LIMITED24 mag 196724 mag 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 dic 2013

    Stato del capitale al 03 dic 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    2 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    15 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Coopers Place Coombe Lane Wormley Godalming Surrey GU8 5SZ United Kingdom

    1 pagineAD02

    Nomina di Patrick Cairns come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Joannes Heemskerk come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joannes Heemskerk come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jason Edward Boxer come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Coopers Place Combe Lane, Wormley Godalming Surrey GU8 5SZ* in data 15 nov 2011

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Yeates come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2009

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Drs Rc Joannes Petrus Theodorus Heemskerk il 19 nov 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di WHOLE EARTH FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOXER, Jason Edward
    c/o Kallo Foods Ltd
    The Meadows Business Park
    Blackwater,
    GU17 9AB Camberley
    River View 2
    Surrey
    England
    Amministratore
    c/o Kallo Foods Ltd
    The Meadows Business Park
    Blackwater,
    GU17 9AB Camberley
    River View 2
    Surrey
    England
    EnglandBritishFinance Director167307930001
    CAIRNS, Patrick David
    c/o Kallo Foods Ltd
    The Meadows Business Park
    Blackwater,
    GU17 9AB Camberley
    River View 2
    Surrey
    England
    Amministratore
    c/o Kallo Foods Ltd
    The Meadows Business Park
    Blackwater,
    GU17 9AB Camberley
    River View 2
    Surrey
    England
    EnglandBritishManaging Director167308460001
    BEART, Nicholas Anthony
    81 Bennerley Road
    SW11 6DT London
    Segretario
    81 Bennerley Road
    SW11 6DT London
    BritishDirector69274920003
    HEEMSKERK, Joannes Petrus Theodorus, Drs Rc
    Brook Road
    GU8 5UH Brook
    West Overton
    Surrey
    Segretario
    Brook Road
    GU8 5UH Brook
    West Overton
    Surrey
    DutchFinance Director136882020001
    KLEEREKOPER, David Jacob
    2 Winchester Close
    KT2 7JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    2 Winchester Close
    KT2 7JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    DutchDirector111072040001
    MILNE, Linda Jane
    Beck Cottage Flexford Road
    Normandy
    GU3 2EE Guildford
    Surrey
    Segretario
    Beck Cottage Flexford Road
    Normandy
    GU3 2EE Guildford
    Surrey
    BritishFinancial Controller38334820001
    REYNOLDS, Andrew David Finch
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    Segretario
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    BritishFinance Director63987530001
    SAMS, Craig Lynn
    269 Portobello Road
    W11 1LR London
    Segretario
    269 Portobello Road
    W11 1LR London
    AmericanCompany Director22234340001
    YEATES, Paul
    10 Belle Baulk
    NN12 6YH Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    10 Belle Baulk
    NN12 6YH Towcester
    Northamptonshire
    BritishManaging Director71252220001
    BEART, Nicholas Anthony
    81 Bennerley Road
    SW11 6DT London
    Amministratore
    81 Bennerley Road
    SW11 6DT London
    BritishDirector69274920003
    HEEMSKERK, Joannes Petrus Theodorus, Drs Rc
    Brook Road
    GU8 5UH Brook
    West Overton
    Surrey
    Amministratore
    Brook Road
    GU8 5UH Brook
    West Overton
    Surrey
    United KingdomDutchFinance Director136882020001
    KENDALL, William Bruce
    By The Crossways
    Kelsale
    IP17 2PL Saxmundham
    Suffolk
    Amministratore
    By The Crossways
    Kelsale
    IP17 2PL Saxmundham
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector76334990001
    KENNEDY, John Patrick
    78 Barnsbury Road
    N1 0ES London
    Amministratore
    78 Barnsbury Road
    N1 0ES London
    BritishCompany Director73815460001
    KLEEREKOPER, David Jacob
    2 Winchester Close
    KT2 7JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    2 Winchester Close
    KT2 7JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    DutchManaging Director111072040001
    MOSS, Clifford James
    Mitchells Church Street
    West Chiltington
    RH20 2JD Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Mitchells Church Street
    West Chiltington
    RH20 2JD Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director38443650002
    ONKENHOUT, Niels Rensen
    Sint Janstraat 54a
    1251 Eg Laren Nh
    Netherlands
    Amministratore
    Sint Janstraat 54a
    1251 Eg Laren Nh
    Netherlands
    DutchDirector96400200001
    REYNOLDS, Andrew David Finch
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    Amministratore
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    United KingdomBritishFinance Director63987530001
    SAMS, Craig Lynn
    269 Portobello Road
    W11 1LR London
    Amministratore
    269 Portobello Road
    W11 1LR London
    AmericanCompany Director22234340001
    SCHAAFSMA, Sjoerd Rienk
    H. Zwaardemakerstraat 21
    1402 Vd Bussum
    The Netherlands
    Amministratore
    H. Zwaardemakerstraat 21
    1402 Vd Bussum
    The Netherlands
    NetherlandsDutchChief Financial Officer Europe125796100001
    TURPIN, Neil Hugh
    2 Harbut Road
    Battersea
    SW11 2RB London
    Amministratore
    2 Harbut Road
    Battersea
    SW11 2RB London
    BritishSales Director73815320001
    VANDEBROEK, Johan Danny Maurice
    Dropstraat 67
    Gelrode
    B-3200
    Belgium
    Amministratore
    Dropstraat 67
    Gelrode
    B-3200
    Belgium
    BelgianDirector81203010001
    WILLS, Alan
    2 Oakley
    BA2 6DS Bath
    Amministratore
    2 Oakley
    BA2 6DS Bath
    BritishManaging Director49106540002
    YEATES, Paul
    10 Belle Baulk
    NN12 6YH Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    10 Belle Baulk
    NN12 6YH Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManaging Director71252220001

    WHOLE EARTH FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 nov 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2002
    Consegnato il 05 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from whole earth limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cadbury Schweppes PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 23RD december 1999
    Brevi particolari
    £24,000 plus vat thereon paid by the tenant to the landlord together with any other sums paid into the account by the tenant and any interest credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Partick Group Limited and Dealfast Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 19 mar 1997
    Consegnato il 26 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the "deposit(s)" and all other monies referred to in account with barclays bank PLC re whole earth foods limited business premium account number 40823066.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture.
    Creato il 06 giu 1991
    Consegnato il 20 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 30/8/88
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a receivables financing deed dated 19TH sept. 1988. and all book debts and other debts the subject of the charged deeds (for full details see form M395 reference M244C).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1991
    Consegnato il 25 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    269 portobello road, london borough of kensington & chelsea.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ago 1988
    Consegnato il 05 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 04 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Floating charge over (see 395.). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Wilson Foods LTD.
    Transazioni
    • 04 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 apr 1987
    Consegnato il 14 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000
    Brevi particolari
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Wilson King (Holdings) LTD
    Transazioni
    • 14 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Loan stock instrument
    Creato il 17 ott 1980
    Consegnato il 31 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 31 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 ott 1975
    Consegnato il 17 ott 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital together with all buildings fixtu res (incl trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0