BRNE REALISATIONS LIMITED

BRNE REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRNE REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00910429
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRNE REALISATIONS LIMITED?

    • Fabbricazione di gioielli e articoli correlati (32120) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hollins Mount
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROWN & NEWIRTH LIMITED11 lug 196711 lug 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ott 2013

    12 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 05 ott 2012

    17 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 05 ago 2012

    16 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed brown & newirth LIMITED\certificate issued on 21/03/12
    3 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 feb 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da Elma House Beaconsfield Close Hatfield Hertfordshire AL10 8YG United Kingdom in data 14 feb 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 feb 2012

    Stato del capitale al 01 feb 2012

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Mark Jason Birchall come amministratore in data 24 dic 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Lazenby come segretario in data 24 dic 2011

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Julie Large come amministratore in data 09 dic 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Lazenby come amministratore in data 24 dic 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sewa Singh Kang come amministratore in data 22 dic 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 28 feb 2011

    27 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB United Kingdom in data 25 nov 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr. John Robert Ball come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    10 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHTON, Simon Mark
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Amministratore
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritish49915710004
    BALL, John Robert, Mr.
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish160952980001
    BIRCHALL, Mark Jason
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Amministratore
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritish70139540002
    BROWN, Zelma
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    British10810020001
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Segretario
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    British138964960001
    LAZENBY, Simon, Mr.
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    155155810001
    SANDERS, Christopher
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    Segretario
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    British22630460001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Segretario
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    British190689780001
    ASHTON, Simon Mark
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish49915710004
    BROWN, Edward Ivor
    2 Aylwards Rise
    HA7 3EH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    2 Aylwards Rise
    HA7 3EH Stanmore
    Middlesex
    British2770090002
    BROWN, Zelma
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    British10810020001
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Amministratore
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    British138964960001
    HAMLEY, Nicholas Peter, Mr.
    Manton House Farm
    Barton Dean
    SN8 4HB Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Manton House Farm
    Barton Dean
    SN8 4HB Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish126433050001
    KANG, Sewa Singh
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandIndian135961150001
    LARGE, Julie
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish157506070001
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish138472720001
    LEVER, Michael Neville
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish12573190001
    POMERANCE, Alex Richard
    18 Folly Close
    WD7 8DR Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    18 Folly Close
    WD7 8DR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish22630450001
    SANDERS, Christopher
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    Amministratore
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish22630460001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    THOMPSON, Scott
    15 Chapmans Close
    Potton
    SG19 2PL Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    15 Chapmans Close
    Potton
    SG19 2PL Sandy
    Bedfordshire
    British53391290003
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish190689780001
    WILLIAMS, Gary Stephen
    33 Lee Grove
    IG7 6AD Chigwell
    Essex
    Amministratore
    33 Lee Grove
    IG7 6AD Chigwell
    Essex
    EnglandBritish22630470002

    BRNE REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 02 feb 2012
    Consegnato il 07 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chrysus Holdco Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 mag 2011
    Consegnato il 06 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Moorgarth Property Investments Limited (Moorgarth)
    Transazioni
    • 06 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 mar 2009
    Consegnato il 21 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Micheal Neville Lever
    Transazioni
    • 21 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 giu 2006
    Consegnato il 23 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a peter rosenberg house 11-15 wilmington grove leeds and all other interests in any f/h or l/h property all fixtures and fittings and fixed plant and machinery its goodwill and its uncalled capital its book debts by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal assignment of contract monies
    Creato il 02 feb 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts between the company and hsbc. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 30 dic 2005
    Consegnato il 03 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 03 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 30 dic 2005
    Consegnato il 03 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 03 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 08 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 giu 2001
    Consegnato il 19 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of security
    Creato il 09 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 3/7/91.
    Brevi particolari
    All amounts which are now or may from time to time hereafter be standing to the credit of the company's account with the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 19 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 dic 1990
    Consegnato il 28 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 6 station close, porter bar, hertfordshire. Title no hd 72186.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 gen 1984
    Consegnato il 20 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 27 april 1978
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 03 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 apr 1978
    Consegnato il 04 mag 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 04 mag 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRNE REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 feb 2012Inizio dell'amministrazione
    05 ott 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Malcolm Titley
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Praticante
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Andrew Poxon
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Praticante
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    2
    DataTipo
    05 ott 2012Inizio della liquidazione
    22 apr 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Malcolm Titley
    Tower 12,18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praticante
    Tower 12,18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Andrew Poxon
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praticante
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0