LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED

LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEX AUTOLEASE (VL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00910788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LLOYDS TSB AUTOLEASE (VL) LIMITED29 lug 200229 lug 2002
    FIRST NATIONAL VEHICLE LEASING LIMITED11 ago 199711 ago 1997
    FREIGHT TRANSPORT LEASING LIMITED07 ago 199707 ago 1997
    FREIGHT TRANSPORT LEASING LIMITED14 lug 196714 lug 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 25 Gresham Street London EC2V 7HN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 11 lug 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2016

    Stato del capitale al 21 giu 2016

    • Capitale: GBP 999
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 lug 2015

    Stato del capitale al 15 lug 2015

    • Capitale: GBP 999
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Claude Kwasi Sarfo-Agyare come amministratore in data 16 dic 2014

    1 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 lug 2014

    Stato del capitale al 15 lug 2014

    • Capitale: GBP 999
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed lloyds tsb autolease (vl) LIMITED\certificate issued on 23/09/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name23 set 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 set 2013

    RES15
    change-of-name23 set 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Carol Ann Parkes il 10 ago 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Carol Ann Parkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 lug 2013

    SH01

    Cessazione della carica di Richard Francis come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare il 24 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    31 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02791894
    73512200003
    PARKES, Carol Ann
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139996590027
    FERRIS, Michael James
    Zitrey
    Cox Hill
    CM6 2HL Great Easton
    Essex
    Segretario
    Zitrey
    Cox Hill
    CM6 2HL Great Easton
    Essex
    British114444730001
    GALVIN, Martin Christopher
    1 Duke Street
    SK13 8JD Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    1 Duke Street
    SK13 8JD Glossop
    Derbyshire
    British16555430001
    HOPKINS, Stephen John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    149228480001
    PAWSON, Michael Andrew
    14 Laurence Court
    Woodlesford
    LS26 8QY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    14 Laurence Court
    Woodlesford
    LS26 8QY Leeds
    West Yorkshire
    British8181070001
    SAUNDERS, Deborah Ann
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Segretario
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Other38589290002
    SMYTH, Margaret
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    British74350280001
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Segretario
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    ABRAMS, Brian
    18 Wentworth Avenue
    Whitefield
    M45 7GQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    18 Wentworth Avenue
    Whitefield
    M45 7GQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish16555480001
    ABRAMS, Eric
    5 Wells Avenue
    Prestwich
    M25 0GN Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    5 Wells Avenue
    Prestwich
    M25 0GN Manchester
    Lancashire
    British6655950001
    ABRAMS, Steven Mark
    33 Delahays Drive
    Hale
    WA15 8DR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    33 Delahays Drive
    Hale
    WA15 8DR Altrincham
    Cheshire
    British16555440001
    BARLEY, Michael James
    20 Saint Matthews Avenue
    KT6 6JJ Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    20 Saint Matthews Avenue
    KT6 6JJ Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish71570430001
    BLACKWELL, Timothy Mark
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Amministratore
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish124967310001
    DAVIES, John Lewis
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    Amministratore
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    British51486560001
    FRANCIS, Rick
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritish180380320001
    GEORGE, Philip Anthony
    Foxgloves
    32 Hempstead Lane Potten End
    HP4 2SD Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Foxgloves
    32 Hempstead Lane Potten End
    HP4 2SD Berkhamsted
    Hertfordshire
    British25753480001
    HOCKEY MORLEY, Gary
    69 Westbury Road
    HA6 3DA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    69 Westbury Road
    HA6 3DA Northwood
    Middlesex
    British78595520001
    KILBEE, Michael Peter
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    British19310990002
    PATEL, Shashin
    91 Chester Drive
    HA2 7PX Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    91 Chester Drive
    HA2 7PX Harrow
    Middlesex
    EnglandBritish79860270001
    PAWSON, Michael Andrew
    8 East Ridge View
    Garforth
    LS25 2PN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 East Ridge View
    Garforth
    LS25 2PN Leeds
    West Yorkshire
    British8181070002
    POTTS, David Keith
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish5774320002
    SARFO-AGYARE, Claude Kwasi
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170061790001
    SCOTT, John Stearn
    Three Elms
    Common Gate Road
    WD3 5JR Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Three Elms
    Common Gate Road
    WD3 5JR Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish7126810001
    SIMPSON, Martin Edward
    2 Green Lane
    Timperley
    WA15 7PF Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    2 Green Lane
    Timperley
    WA15 7PF Altrincham
    Cheshire
    British64225390001
    SMYTH, Margaret
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish74350280001
    SMYTH, Michael
    Brookdale Brookbottom
    Riding Gate Harwood
    BL2 4DL Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Brookdale Brookbottom
    Riding Gate Harwood
    BL2 4DL Bolton
    Lancashire
    British33134410001
    SNARR, Peter David
    80 Grasmere
    SK11 8PL Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    80 Grasmere
    SK11 8PL Macclesfield
    Cheshire
    British30021640001
    STAPLES, Martin Kenneth
    1 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Princes Exchange
    Scotland
    Amministratore
    1 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Princes Exchange
    Scotland
    ScotlandBritish110383950001
    STEAD, Nigel Cleator
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    EnglandBritish47582470001
    STUDHOLME, Dennis
    Moorlands 89 Chapeltown Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Moorlands 89 Chapeltown Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish13723760003
    STURT SCOBIE, James
    Hazelhurst
    Willow Hall Drive
    HX6 2BL Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hazelhurst
    Willow Hall Drive
    HX6 2BL Halifax
    West Yorkshire
    British65652830001
    TYLDSLEY, William Andrew
    Hermosa
    Troutbeck Close Hawkshaw
    BL8 4LJ Bury
    Greater Manchester
    Amministratore
    Hermosa
    Troutbeck Close Hawkshaw
    BL8 4LJ Bury
    Greater Manchester
    United KingdomBritish36851690001
    WHITE, Adrian Patrick
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Amministratore
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish130578200001

    LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Certificate of assignment
    Creato il 10 ago 1994
    Consegnato il 11 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 04 gen 1994
    Consegnato il 13 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 08 dic 1993
    Consegnato il 11 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefit & interest in & to sub hire agreements & the benefit of all guarantees etc.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 01 dic 1993
    Consegnato il 04 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to sub-hire agreements benefit of all guarantees securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Transport Leasing
    Transazioni
    • 04 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 08 nov 1993
    Consegnato il 13 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 08 nov 1993
    Consegnato il 13 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 12 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a hire purchase agreement dated 22/03/93
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 09 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire agreements interim finance documents and the legal charge dated 7TH may 1993
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in or arising out of the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transazioni
    • 09 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 07 ott 1993
    Consegnato il 12 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to the sub-hire agreements made between freight transport leasing limited and bedfordshire county council. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 23 set 1993
    Consegnato il 28 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in connection with the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 28 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 06 set 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 12 ago 1993
    Consegnato il 01 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a purchase agreement dated 22ND march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 01 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 12 ago 1993
    Consegnato il 20 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 27 lug 1993
    Consegnato il 20 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 05 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master charge dated 07/05/93 (as defined)
    Brevi particolari
    All its right,title,benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary,contractual or otherwise under or arising out of or in respect of the agreements 8339.
    Persone aventi diritto
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 29 giu 1993
    Consegnato il 02 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a master charge dated 7TH may 1993
    Brevi particolari
    All rights title benefits and interest of the company under or arising out of or in respect of the agreements.
    Persone aventi diritto
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 24 giu 1993
    Consegnato il 05 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22 march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to sub-hire agreements made between the company and bedfordshire county council and the benefit of all guarantees,indemnities,negotiable instruments and securities.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 23 giu 1993
    Consegnato il 05 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22 march 1993
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and to sub-hire agreements made between the company and bedfordshire county council and the benefit of all guarantees,indemnities,negotiable instruments and securities.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 25 mag 1993
    Consegnato il 04 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/3/93
    Brevi particolari
    All rights benefit & interest in & to the sub hire agreements made between the company & bedfordshire county council & the benefit of all guarantees indemnities & securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sub-hire agreements
    Creato il 07 mag 1993
    Consegnato il 24 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the agreements,any interim finance document and any other agreement or arrangement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all the sub hire agreements details of which sre set out on the schedule attached to form 395 (please see form 395 M53C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 26 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge without written instrument
    Creato il 03 apr 1993
    Consegnato il 05 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £32,131.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 29/01/89
    Brevi particolari
    The agreements specified in the schedule to form 395 together with all the company's rights and benefits thereunder and the goods the subjects of the agreements.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 05 apr 1993Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 mar 1993
    Consegnato il 13 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    All rights title & interest present & future in & to the sub hire agreements (for full details refer to doc M395 ).
    Persone aventi diritto
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 14 lug 1992
    Consegnato il 17 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements entered into and to be entered into between the chargee and the company and all costs charges and expenses incurred by the chargee to enforce any of the provisions of the master assignment dated 08/11/88
    Brevi particolari
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the assignment please refer to form 395 for full details of the property charged.
    Persone aventi diritto
    • Nws 6 Limited
    Transazioni
    • 17 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 29 giu 1992
    Consegnato il 30 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements dated 29/06/92
    Brevi particolari
    A first fixed charge over all rights and interest of the company under hire agreements the vehicles all monies (see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 30 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 11 mag 1992
    Consegnato il 12 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to nws 1 under the terms of the agreements entered into from time to time between the company and nws 1 and all costs and charges incurred by nws 1 to enforce the provisions of the master assignment
    Brevi particolari
    All monies due and to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nws 2
    Transazioni
    • 12 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 giu 2016Inizio della liquidazione
    13 ott 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0