PEDIGREE NO. 1 LIMITED

PEDIGREE NO. 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEDIGREE NO. 1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00918540
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    • Produzione di birra (11050) / Industrie manifatturiere
    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEDIGREE NO. 1 PLC24 mar 199924 mar 1999
    MORAY FIRTH MALTINGS PLC17 ott 196717 ott 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 24/11/2014
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Malcolm Dunn come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Michael Forde come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sean Michael Paterson come amministratore in data 08 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come amministratore in data 06 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come segretario in data 06 ott 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 14 ott 2013

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Kelly Taylor-Welsh il 14 ott 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Michael Paterson il 14 ott 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 14 ott 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    28 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Chi sono gli amministratori di PEDIGREE NO. 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNN, Malcolm James Shiel
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish191401290001
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    TAYLOR-WELSH, Kelly
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish167915590003
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Segretario
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    British132259650001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOWIE, Robin Yule
    110 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JS Dundee
    Angus
    Segretario
    110 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JS Dundee
    Angus
    British922440001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Segretario
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    RAWSON, Ian Michael Gilmour
    Old Blair
    Blair Atholl
    PH18 5TX Pitlochry
    Perthshire
    Segretario
    Old Blair
    Blair Atholl
    PH18 5TX Pitlochry
    Perthshire
    British46788880001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Segretario
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Amministratore
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritish132259650001
    ELLIS, Peter James
    Old Balmacron
    Meigle
    PH12 8RW Blairgowrie
    Perthshire
    Amministratore
    Old Balmacron
    Meigle
    PH12 8RW Blairgowrie
    Perthshire
    British52570001
    GIBBS, Somerset Bryan
    Witcham House
    Witcham
    CB6 2LH Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Witcham House
    Witcham
    CB6 2LH Ely
    Cambridgeshire
    British15403910001
    GORE, John Richard
    The Stables
    Tyninghame House
    EH42 1XW East Linton
    East Lothian
    Amministratore
    The Stables
    Tyninghame House
    EH42 1XW East Linton
    East Lothian
    British44540200001
    GRIEVE, Douglas William
    Welton House
    Coupar Angus
    PH13 9EY Blairgowrie
    Perthshire
    Amministratore
    Welton House
    Coupar Angus
    PH13 9EY Blairgowrie
    Perthshire
    British37359930001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOWIE, Robin Yule
    110 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JS Dundee
    Angus
    Amministratore
    110 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JS Dundee
    Angus
    British922440001
    ILES, Michael Charles
    74 Caesar Avenue
    DD7 6DS Carnoustie
    Angus
    Amministratore
    74 Caesar Avenue
    DD7 6DS Carnoustie
    Angus
    British317680001
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish162758370001
    MACKAY, Eileen Alison
    26 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    26 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Midlothian
    British18304510001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    MORGAN, Anthony John
    Jeaniebank
    Stormontfield
    PH2 6BQ Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Jeaniebank
    Stormontfield
    PH2 6BQ Perth
    Perthshire
    British3210570001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish132910690001
    PAGE CROFT, Hugo Douglas
    Castlebury,
    Bakers End
    SG12 7SH Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Castlebury,
    Bakers End
    SG12 7SH Ware
    Hertfordshire
    UkBritish54168330001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish141021760002
    PAYNE, William John
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    Amministratore
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    ScotlandBritish136005370001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    RAWSON, Ian Michael Gilmour
    Old Blair
    Blair Atholl
    PH18 5TX Pitlochry
    Perthshire
    Amministratore
    Old Blair
    Blair Atholl
    PH18 5TX Pitlochry
    Perthshire
    British46788880001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Amministratore
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    SUMMERS, Roy, Dr
    Ettrick Manor 56/6 Spylaw Road
    EH10 5BR Edinburgh
    Amministratore
    Ettrick Manor 56/6 Spylaw Road
    EH10 5BR Edinburgh
    ScotlandBritish629680006
    TEDFORD, Craig
    2 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NB Glasgow
    Amministratore
    2 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NB Glasgow
    United KingdomBritish106867030001
    WARD, Thomas Richard
    4 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Amministratore
    4 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    ScotlandBritish45288010001
    WILKINSON, Derek Macgregor
    4 Lauder Road
    EH9 2EL Edinburgh
    Amministratore
    4 Lauder Road
    EH9 2EL Edinburgh
    British629280002
    WILKINSON, Derek Macgregor
    21 Crawford Road
    EH16 5PQ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    21 Crawford Road
    EH16 5PQ Edinburgh
    Midlothian
    British629280001
    SCOTTISH & NEWCASTLE BREWERIES(SERVICES) LIMITED
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    68666210006

    PEDIGREE NO. 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of offset
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 04 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 ott 1975
    Consegnato il 24 ott 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the barley harvest purchase facilities dated 20/10/75
    Brevi particolari
    Floating charge over undertaking goodwill all property and assets present and future including uncalled capital (see doc M59).
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Finance Co LTD
    Transazioni
    • 24 ott 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 31 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0