CABCON (UK) LIMITED

CABCON (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCABCON (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00918865
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CABCON (UK) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CABCON (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    Surrey
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CABCON (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TECHLINEAR LIMITED19 ott 196719 ott 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di CABCON (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per CABCON (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 04 apr 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Acal Plc come persona con controllo significativo il 01 giu 2022

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Gregory Davidson-Shrine come amministratore in data 17 dic 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gregory Davidson-Shrine come segretario in data 04 dic 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nicholas Rowe come segretario in data 04 dic 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Nicholas Rowe come segretario in data 02 set 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Joanna Alwen Harkus Madge come amministratore in data 02 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanna Alwen Harkus Madge come segretario in data 02 set 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CABCON (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIDSON-SHRINE, Gregory
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    265034320001
    DAVIDSON-SHRINE, Gregory
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish169072790002
    GIBBINS, Simon Mark
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish153156670001
    BITHELL, Charles Peter
    82 Harpesford Avenue
    GU25 4RE Virginia Water
    Surrey
    Segretario
    82 Harpesford Avenue
    GU25 4RE Virginia Water
    Surrey
    British70732940001
    BRAIN, Simon
    Jangas House
    Sandpits Lane
    GL9 1BD Hawkesbury Upton
    South Gloucestershire
    Segretario
    Jangas House
    Sandpits Lane
    GL9 1BD Hawkesbury Upton
    South Gloucestershire
    British90112710001
    GRANSBURY, Peter Alan
    16 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    16 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British10002720001
    HARKUS MADGE, Joanna Alwen
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    228498680001
    LLOYD, Nigel
    12 Bencombe Road
    SL7 3NZ Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Segretario
    12 Bencombe Road
    SL7 3NZ Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    British48756930001
    POMEROY, John Victor
    2 Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    Segretario
    2 Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    British94823610002
    ROWE, Nicholas
    Somerton
    OX25 6NB Oxford
    Wychwood Cottages
    Oxon
    United Kingdom
    Segretario
    Somerton
    OX25 6NB Oxford
    Wychwood Cottages
    Oxon
    United Kingdom
    262010090001
    ROWE, Nicholas
    Somerton
    OX25 6NB Oxford
    Wychwood Cottages
    Oxon
    Segretario
    Somerton
    OX25 6NB Oxford
    Wychwood Cottages
    Oxon
    British133905500001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Monkshanger
    Farnham
    9
    Surrey
    England
    Segretario
    Monkshanger
    Farnham
    9
    Surrey
    England
    British140000640001
    COOPER, Malcolm Howard
    Malthouse Close
    GU52 6TB Church Crookham
    24
    Hampshire
    Amministratore
    Malthouse Close
    GU52 6TB Church Crookham
    24
    Hampshire
    EnglandBritish152298610001
    CURRY, John Arthur Hugh
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Amministratore
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritish2968140002
    GRANSBURY, Peter Alan
    16 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British10002720001
    HARKUS MADGE, Joanna Alwen
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish228341780001
    LAUGHTON, Anthony Joseph
    The Old House
    Frensham
    GU10 3EF Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Old House
    Frensham
    GU10 3EF Farnham
    Surrey
    British70673560001
    POWELL, Bruce Lewis Hamilton
    Broadhatch House
    Bentley
    GU10 5JJ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Broadhatch House
    Bentley
    GU10 5JJ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish15809770001
    RIDGEWELL, Maurice John
    Fineshade Wey Road
    KT13 8HW Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Fineshade Wey Road
    KT13 8HW Weybridge
    Surrey
    British10002730001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    EnglandBritish66825690001
    SYDES, Stephen Charles
    Highfields
    RG21 3PH Overton
    1
    Hampshire
    Amministratore
    Highfields
    RG21 3PH Overton
    1
    Hampshire
    BerkshireBritish133156410001
    VIRDEE, Jagjit Singh
    33 Atkins Road
    SW12 0AA London
    Amministratore
    33 Atkins Road
    SW12 0AA London
    British28012500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CABCON (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Chancellor Court
    Occam Road Surrey Research Park
    GU2 7AH Guildford
    2
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02008246
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CABCON (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 mag 1984
    Consegnato il 25 mag 1984
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 gladstone cottages wimborne avenue southall middlesex title no ngl 347419 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 19 mar 1984
    Consegnato il 21 mar 1984
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc 43). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 21 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 03 set 1976
    Consegnato il 09 set 1976
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the together with fixed plant machinery fixtures implements and utensils. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 09 set 1976Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 gen 1975
    Consegnato il 18 feb 1975
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 gladstone cottages, wimborne avenue, southall, middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 feb 1975Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0