CABCON (UK) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CABCON (UK) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00918865 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CABCON (UK) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CABCON (UK) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CABCON (UK) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TECHLINEAR LIMITED | 19 ott 1967 | 19 ott 1967 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CABCON (UK) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per CABCON (UK) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 04 apr 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Acal Plc come persona con controllo significativo il 01 giu 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gregory Davidson-Shrine come amministratore in data 17 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gregory Davidson-Shrine come segretario in data 04 dic 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Rowe come segretario in data 04 dic 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicholas Rowe come segretario in data 02 set 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanna Alwen Harkus Madge come amministratore in data 02 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanna Alwen Harkus Madge come segretario in data 02 set 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CABCON (UK) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Segretario | Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford 2 Surrey United Kingdom | 265034320001 | |||||||
| DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Amministratore | Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford 2 Surrey United Kingdom | England | British | 169072790002 | |||||
| GIBBINS, Simon Mark | Amministratore | Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford 2 Surrey United Kingdom | England | British | 153156670001 | |||||
| BITHELL, Charles Peter | Segretario | 82 Harpesford Avenue GU25 4RE Virginia Water Surrey | British | 70732940001 | ||||||
| BRAIN, Simon | Segretario | Jangas House Sandpits Lane GL9 1BD Hawkesbury Upton South Gloucestershire | British | 90112710001 | ||||||
| GRANSBURY, Peter Alan | Segretario | 16 Seer Mead Seer Green HP9 2QL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 10002720001 | ||||||
| HARKUS MADGE, Joanna Alwen | Segretario | Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford 2 Surrey United Kingdom | 228498680001 | |||||||
| LLOYD, Nigel | Segretario | 12 Bencombe Road SL7 3NZ Marlow Bottom Buckinghamshire | British | 48756930001 | ||||||
| POMEROY, John Victor | Segretario | 2 Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford | British | 94823610002 | ||||||
| ROWE, Nicholas | Segretario | Somerton OX25 6NB Oxford Wychwood Cottages Oxon United Kingdom | 262010090001 | |||||||
| ROWE, Nicholas | Segretario | Somerton OX25 6NB Oxford Wychwood Cottages Oxon | British | 133905500001 | ||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Segretario | Monkshanger Farnham 9 Surrey England | British | 140000640001 | ||||||
| COOPER, Malcolm Howard | Amministratore | Malthouse Close GU52 6TB Church Crookham 24 Hampshire | England | British | 152298610001 | |||||
| CURRY, John Arthur Hugh | Amministratore | Stokewood Park House Sheardley Lane Droxford SO32 3QY Southampton | England | British | 2968140002 | |||||
| GRANSBURY, Peter Alan | Amministratore | 16 Seer Mead Seer Green HP9 2QL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 10002720001 | ||||||
| HARKUS MADGE, Joanna Alwen | Amministratore | Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford 2 Surrey United Kingdom | England | British | 228341780001 | |||||
| LAUGHTON, Anthony Joseph | Amministratore | The Old House Frensham GU10 3EF Farnham Surrey | British | 70673560001 | ||||||
| POWELL, Bruce Lewis Hamilton | Amministratore | Broadhatch House Bentley GU10 5JJ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 15809770001 | |||||
| RIDGEWELL, Maurice John | Amministratore | Fineshade Wey Road KT13 8HW Weybridge Surrey | British | 10002730001 | ||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Amministratore | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | England | British | 66825690001 | |||||
| SYDES, Stephen Charles | Amministratore | Highfields RG21 3PH Overton 1 Hampshire | Berkshire | British | 133156410001 | |||||
| VIRDEE, Jagjit Singh | Amministratore | 33 Atkins Road SW12 0AA London | British | 28012500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CABCON (UK) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discoverie Group Plc | 06 apr 2016 | Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford 2 Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CABCON (UK) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 21 mag 1984 Consegnato il 25 mag 1984 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 1 gladstone cottages wimborne avenue southall middlesex title no ngl 347419 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 mar 1984 Consegnato il 21 mar 1984 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See doc 43). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 set 1976 Consegnato il 09 set 1976 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge on the together with fixed plant machinery fixtures implements and utensils. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 gen 1975 Consegnato il 18 feb 1975 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 2 gladstone cottages, wimborne avenue, southall, middlesex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0