LOGICAL COMMERCE LIMITED

LOGICAL COMMERCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOGICAL COMMERCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00919643
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DIAMOND PLATFORMS LIMITED08 nov 199508 nov 1995
    EXETER HIRE CENTRE LIMITED25 ott 196725 ott 1967

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Jerome Sarragozi come segretario in data 30 apr 2019

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 25 gen 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 gen 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Jerome Sarragozi come segretario in data 28 lug 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Andrew Cole come segretario in data 28 lug 2017

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Donald Thomas Kenny il 24 lug 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Thomas Anthony Murray come amministratore in data 01 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Stuart Merrell come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Jeremy Peter Fish come amministratore in data 28 feb 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Indirizzo della sede legale modificato da 145-157 st. John Street London EC1V 4PY a 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN in data 31 ago 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Stuart Merrell come segretario in data 07 apr 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Richard Andrew Cole come segretario in data 07 apr 2016

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2015

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KENNY, Thomas Donald
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandIrish165677760002
    MURRAY, Thomas Anthony
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish198214500001
    COLE, Richard Andrew
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Segretario
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    207374600001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    Segretario
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    HILL, Percy James Hannaford
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    Segretario
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    British34368290001
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Segretario
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    British59110640004
    SARRAGOZI, Jerome
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    236102320001
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    Segretario
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    APPLETON, Kevin Andrew
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish67821450016
    BAKER, Austin Philip
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    British44426070001
    FISH, Jeremy Peter
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish160373640001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    Amministratore
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    GANSSER-POTTS, Michael David
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    Amministratore
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    EnglandBritish158445070001
    GESTETNER, Geoffrey Sigmund
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    Amministratore
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    British47136960001
    MCMEEKING, Robert John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish75448720003
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish59110640004
    PRICE, David Lawrence
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    Amministratore
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    British25187800003
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    Amministratore
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    TANNER, Cecilia Kathleen Bessie
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    Amministratore
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British24926770001
    TANNER, Charles Derek
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    Amministratore
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British79342340001
    TANNER, Dale Charles
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    Amministratore
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    British43117330002
    WRIGHT, Andrew John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish122845150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Zooom Holdings (Uk) Limited
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    06 apr 2016
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione4812536
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LOGICAL COMMERCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 08 mar 2012
    Consegnato il 27 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 18 nov 2009
    Consegnato il 27 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and/or Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 set 2008
    Consegnato il 20 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 20 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 20 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 giu 1991
    Consegnato il 19 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1989
    Consegnato il 29 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87
    Creato il 23 gen 1987
    Consegnato il 24 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1981
    Consegnato il 25 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 27 fore street, exmouth, devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1981
    Consegnato il 25 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 07 apr 1981
    Consegnato il 09 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust LTD
    Transazioni
    • 09 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 08 lug 1977
    Consegnato il 28 lug 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731.
    Persone aventi diritto
    • E.J.Allen.
    Transazioni
    • 28 lug 1977Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 24 ago 1972
    Consegnato il 30 ago 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 mag 1968
    Consegnato il 08 mag 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1968Registrazione di un'ipoteca

    LOGICAL COMMERCE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 gen 2019Inizio della liquidazione
    06 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0