LOGICAL COMMERCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LOGICAL COMMERCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00919643 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LOGICAL COMMERCE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DIAMOND PLATFORMS LIMITED | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 |
| EXETER HIRE CENTRE LIMITED | 25 ott 1967 | 25 ott 1967 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jerome Sarragozi come segretario in data 30 apr 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 25 gen 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jerome Sarragozi come segretario in data 28 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Andrew Cole come segretario in data 28 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Donald Thomas Kenny il 24 lug 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas Anthony Murray come amministratore in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Stuart Merrell come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeremy Peter Fish come amministratore in data 28 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 145-157 st. John Street London EC1V 4PY a 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN in data 31 ago 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Stuart Merrell come segretario in data 07 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Richard Andrew Cole come segretario in data 07 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY, Thomas Donald | Amministratore | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | Irish | 165677760002 | |||||
| MURRAY, Thomas Anthony | Amministratore | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | 198214500001 | |||||
| COLE, Richard Andrew | Segretario | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | 207374600001 | |||||||
| FRANKLIN, Karen Jane | Segretario | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | 24926760001 | ||||||
| HILL, Percy James Hannaford | Segretario | 65 Southfield Avenue TQ3 1LQ Paignton Devon | British | 34368290001 | ||||||
| MERRELL, Alan Stuart | Segretario | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | British | 59110640004 | ||||||
| SARRAGOZI, Jerome | Segretario | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | 236102320001 | |||||||
| SHIPMAN, David Cyril | Segretario | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | 77501360001 | ||||||
| APPLETON, Kevin Andrew | Amministratore | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | England | British | 67821450016 | |||||
| BAKER, Austin Philip | Amministratore | 4 Meadowcroft Drive Kingsteignton TQ12 3PB Newton Abbot Devon | British | 44426070001 | ||||||
| FISH, Jeremy Peter | Amministratore | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | British | 160373640001 | |||||
| FRANKLIN, Karen Jane | Amministratore | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | 24926760001 | ||||||
| GANSSER-POTTS, Michael David | Amministratore | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire | England | British | 158445070001 | |||||
| GESTETNER, Geoffrey Sigmund | Amministratore | Flat 5 160 Gloucester Terrace W2 6HR London | British | 47136960001 | ||||||
| MCMEEKING, Robert John | Amministratore | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 75448720003 | |||||
| MERRELL, Alan Stuart | Amministratore | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 59110640004 | |||||
| PRICE, David Lawrence | Amministratore | Brook Farm Luddington In Th Brook PE28 0HB Oundle Northamptonshire | British | 25187800003 | ||||||
| SHIPMAN, David Cyril | Amministratore | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | 77501360001 | ||||||
| TANNER, Cecilia Kathleen Bessie | Amministratore | Three Tors Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | 24926770001 | ||||||
| TANNER, Charles Derek | Amministratore | Three Tors 66 Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | 79342340001 | ||||||
| TANNER, Dale Charles | Amministratore | 5 Fair Isle Close Scotts Meadow Barton TQ2 7BT Torquay Devon | British | 43117330002 | ||||||
| WRIGHT, Andrew John | Amministratore | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 122845150001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zooom Holdings (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LOGICAL COMMERCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Creato il 08 mar 2012 Consegnato il 27 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 18 nov 2009 Consegnato il 27 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 set 2008 Consegnato il 20 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 mar 1999 Consegnato il 20 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 18 giu 1991 Consegnato il 19 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 nov 1989 Consegnato il 29 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87 | Creato il 23 gen 1987 Consegnato il 24 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 ago 1981 Consegnato il 25 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 27 fore street, exmouth, devon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 ago 1981 Consegnato il 25 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 07 apr 1981 Consegnato il 09 apr 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 08 lug 1977 Consegnato il 28 lug 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 24 ago 1972 Consegnato il 30 ago 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due etc. | |
Brevi particolari Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 01 mag 1968 Consegnato il 08 mag 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due etc. | |
Brevi particolari Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LOGICAL COMMERCE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0