SPEEDY HIRE PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPEEDY HIRE PLC
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00927680
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di SPEEDY HIRE PLC?

    • Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a. (77390) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SPEEDY HIRE PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Chase House
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton Le Willows
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPEEDY HIRE PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALLEN PLC31 mag 198931 mag 1989
    ALLEN HOLDINGS (UK) LIMITED20 lug 198420 lug 1984
    ALLEN BROTHERS (LANCASHIRE) LIMITED22 feb 196822 feb 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPEEDY HIRE PLC?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2026
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2025

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SPEEDY HIRE PLC?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al19 ago 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma02 set 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al19 ago 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per SPEEDY HIRE PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Robert Barclay come amministratore in data 04 set 2025

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzioni

    Re: a general meeting of the company, other than an annual general meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. 04/09/2025
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2025

    174 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ago 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 009276800032 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 009276800034 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 009276800033 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 009276800035, creata il 24 apr 2025

    23 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 009276800036, creata il 24 apr 2025

    59 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzioni

    Market purchases maximum number 46,183,735 minimum price which may be paid for each such maximum price is higher pf 105% 05/09/2024
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Vendita o cessione di azioni di tesoreria. Capitale di tesoreria:

    • Capitale: GBP 2,596,842.7
    2 pagineSH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024

    170 pagineAA

    Acquisto di azioni proprie. Azioni acquistate per la tesoreria:

    • Capitale: GBP 2,597,073.9
    3 pagineSH03
    Note
    DataNota
    27 ott 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023

    190 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzioni

    That a general meeting of the company, other than an annual general meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. 07/09/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Nomina di Mr Paul Adrian Rayner come amministratore in data 01 lug 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Acquisto di azioni proprie. Azioni acquistate per la tesoreria:

    • Capitale: GBP 2,532,630.95
    3 pagineSH03
    Note
    DataNota
    14 giu 2023Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Chi sono gli amministratori di SPEEDY HIRE PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUNT, Neil John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Segretario
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    228193130001
    BARTLETT, Rhian Helen
    Chase House
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton Le Willows
    Merseyside
    Amministratore
    Chase House
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton Le Willows
    Merseyside
    United KingdomBritish238325500001
    DASANI, Shatish Damodar
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish132555670003
    EVANS, Daniel John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish272760890001
    GARMAN, David Noel Christopher
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish220510180001
    KAVANAGH, Carol
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish283824030001
    RAYNER, Paul Adrian
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    SHEARER, David James Buchanan
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish214451420001
    BLAIR, James Edward
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Segretario
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    168697390001
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Segretario
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    British11806560001
    KONCAREVIC, Suzana
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Segretario
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    British139800190001
    MCGRATH, Michael Andrew
    Abbey Barn
    Macclesfield Road
    SK11 9AH Chelford
    Cheshire
    Segretario
    Abbey Barn
    Macclesfield Road
    SK11 9AH Chelford
    Cheshire
    British82005890002
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    RAWNSLEY, Patrick James
    Grove Avenue
    LS29 9PL Ilkley
    The Ghyll
    West Yorkshire
    Segretario
    Grove Avenue
    LS29 9PL Ilkley
    The Ghyll
    West Yorkshire
    Other108571170002
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Segretario
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    ASTRAND, Jan Gunnar
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandSwedish76435330004
    ATKINSON, Peter Duncan
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish18525420002
    AVERILL, Michael Charles Edward
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish24913560002
    BARCLAY, Robert
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish124856170002
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish11806560001
    BUNN, James Richard
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish274171570001
    CONTRERAS, Robert Leonard
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish93499270002
    CORCORAN, Steven James
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish39358260003
    DAVIES, Nicholas William
    Hazel Way
    Linby
    NG15 8GS Nottingham
    17
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Hazel Way
    Linby
    NG15 8GS Nottingham
    17
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish44011700002
    DEE, Frank Rigby
    6 Grosvenor Crescent Mews
    SW1X 7EU London
    Amministratore
    6 Grosvenor Crescent Mews
    SW1X 7EU London
    EnglandBritish143265460001
    DOWN, Russell
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish253603400001
    FOX, Kenneth
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish15540580001
    GALLOWAY, David Allistair
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    Amministratore
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    EnglandBritish180591130001
    GODWIN, Charles Richard
    Greencroft
    Priest Lane
    LA11 6PT Cartmel
    Cumbria
    Amministratore
    Greencroft
    Priest Lane
    LA11 6PT Cartmel
    Cumbria
    EnglandEnglish3414100001
    GREENHALGH, Donald
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    Amministratore
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    British47084170002
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Amministratore
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    British53010640001
    HILTON, Ian John
    120 Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    120 Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    British9601490002
    KRIGE, Lynette Gillian
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish90566820002
    MACPHERSON, Ishbel Jean Stewart
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish151546810001
    MASTERS, Christopher
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish162773310001

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0