C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED

C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00929244
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o INTERIOR SERVICES GROUP PLC (FAO J CRANNEY)
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEARCE CONSTRUCTION (SOUTH WEST) LIMITED01 dic 198701 dic 1987
    C H PEARCE & SONS (CONTRACTORS) LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    C.H. PEARCE & SONS LIMITED21 mar 196821 mar 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2012

    Stato del capitale al 01 giu 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Parklands, Hambrook Lane Stoke Gifford, Bristol, BS34 8QU in data 03 apr 2012

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 mar 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Timothy Nicholas Leigh come amministratore in data 15 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Colin Ian Forrest come amministratore in data 31 gen 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per David Lawther il 31 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Nicholas Leigh il 31 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Charles Bennett Houlton il 31 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Ian Forrest il 31 mag 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    3 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O 31/05/2010 Aldgate House 33 Aldgate High Street London EC3N 1AG United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Jared Stephen Philip Cranney il 31 mag 2010

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Andrew Staniforth come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRANNEY, Jared Stephen Philip
    c/o C/O Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o C/O Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    British74806700006
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    United KingdomBritish70905760002
    LAWTHER, David
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    United KingdomBritish126540420001
    HERRING, Brian William
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    Segretario
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    British54999000001
    LEIGH, Timothy Nicholas
    21 Beaconsfield Road
    Knowle
    BS4 2JE Bristol
    Segretario
    21 Beaconsfield Road
    Knowle
    BS4 2JE Bristol
    British28351320001
    ADAMS, Alan John
    Wesley Combe 19 Whitecroft
    Nailsworth
    GL6 0NS Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Wesley Combe 19 Whitecroft
    Nailsworth
    GL6 0NS Stroud
    Gloucestershire
    British28351290001
    BATES, David Leonard
    Anjo 16 Bleadon Mill
    BS24 0BE Bleadon
    Avon
    Amministratore
    Anjo 16 Bleadon Mill
    BS24 0BE Bleadon
    Avon
    British10031440002
    BRADLEY, Robert
    Foxfield
    Scot Lane, Chew Stoke
    BS40 8UW Bristol
    Amministratore
    Foxfield
    Scot Lane, Chew Stoke
    BS40 8UW Bristol
    British96305270001
    CLARK, Peter Arnold
    10 Down Road
    Winterbourne Down
    BS17 1BN Bristol
    Avon
    Amministratore
    10 Down Road
    Winterbourne Down
    BS17 1BN Bristol
    Avon
    British10377700001
    COLES, Roger Lindsey
    Siston Court Cottage
    Magotsfield
    BS17 3LU Bristol
    Avon
    Amministratore
    Siston Court Cottage
    Magotsfield
    BS17 3LU Bristol
    Avon
    British28351300001
    CRIPPS, Bernard John
    34 Chock Lane
    Westbury-On-Trym
    BS9 3EX Bristol
    Amministratore
    34 Chock Lane
    Westbury-On-Trym
    BS9 3EX Bristol
    British1926290001
    DRYSDALE, Michael John
    12 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RQ Bristol
    Amministratore
    12 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RQ Bristol
    UkBritish91324630001
    FORREST, Colin Ian
    Parklands
    Hambrook Lane Stoke Gifford
    BS34 8QU Bristol
    Amministratore
    Parklands
    Hambrook Lane Stoke Gifford
    BS34 8QU Bristol
    United KingdomBritish56892240002
    GILTSOFF, Mark
    10 Stoke Park Road
    Stoke Bishop
    BS9 1LF Bristol
    Amministratore
    10 Stoke Park Road
    Stoke Bishop
    BS9 1LF Bristol
    British94679290001
    GREENHALGH, Peter Gerard
    Garston Farm
    Garston
    BA11 1RU Frome
    Somerset
    Amministratore
    Garston Farm
    Garston
    BA11 1RU Frome
    Somerset
    United KingdomBritish83636780001
    HERRING, Brian William
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    Amministratore
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    British54999000001
    JONES, Graham Roger David
    Avondale
    London Road East Bathford
    BA1 7RB Bath
    Avon
    Amministratore
    Avondale
    London Road East Bathford
    BA1 7RB Bath
    Avon
    British10377720002
    LEIGH, Timothy Nicholas
    Parklands
    Hambrook Lane Stoke Gifford
    BS34 8QU Bristol
    Amministratore
    Parklands
    Hambrook Lane Stoke Gifford
    BS34 8QU Bristol
    United KingdomBritish28351320001
    NEILE, Ian David
    52 Dorset Way
    North Yate
    BS37 7SP Bristol
    Amministratore
    52 Dorset Way
    North Yate
    BS37 7SP Bristol
    British58671410001
    RACKSTRAW, John William
    Snowberry House Pelting Road
    Priddy
    BA5 3BA Wells
    Somerset
    Amministratore
    Snowberry House Pelting Road
    Priddy
    BA5 3BA Wells
    Somerset
    EnglandBritish16851180001
    RITCHIE, James
    1 Farmcote
    Alderley Road
    GL12 7RP Hillesley
    Gloucestershire
    Amministratore
    1 Farmcote
    Alderley Road
    GL12 7RP Hillesley
    Gloucestershire
    British89095700001
    ROSS, Donald
    Cherry Cottage The Follies
    Rectory Lane Cromhall
    GL12 8AN Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cherry Cottage The Follies
    Rectory Lane Cromhall
    GL12 8AN Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British10377750002
    STANIFORTH, Andrew John
    Clos Coed Hir
    Whitchurch
    CF14 7BJ Cardiff
    26
    Amministratore
    Clos Coed Hir
    Whitchurch
    CF14 7BJ Cardiff
    26
    United KingdomBritish142609680001
    TROTTER, Steve
    Kebbles
    Burford Road
    GL7 3ET Lechlade
    Gloucestershire
    Amministratore
    Kebbles
    Burford Road
    GL7 3ET Lechlade
    Gloucestershire
    United KingdomBritish126539650001
    WILLIAMS, John David
    9 Priory Avenue
    Westbury On Trym
    BS9 4DA Bristol
    Amministratore
    9 Priory Avenue
    Westbury On Trym
    BS9 4DA Bristol
    British77515470001

    C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 14/06/1999
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 05 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts for the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the banks name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 31 gen 2003
    Consegnato il 06 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 ago 1979
    Consegnato il 08 ago 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    152-162 kings road chelsea 8.24 jubilee place & joubert studios chelsea site of classic cinema kings road land at back of 58 markham street chelsea london title no: ngl 278092.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank LTD
    Transazioni
    • 08 ago 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0