C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00929244 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o INTERIOR SERVICES GROUP PLC (FAO J CRANNEY) Aldgate House 33 Aldgate High Street EC3N 1AG London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PEARCE CONSTRUCTION (SOUTH WEST) LIMITED | 01 dic 1987 | 01 dic 1987 |
| C H PEARCE & SONS (CONTRACTORS) LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| C.H. PEARCE & SONS LIMITED | 21 mar 1968 | 21 mar 1968 |
Quali sono gli ultimi bilanci di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Parklands, Hambrook Lane Stoke Gifford, Bristol, BS34 8QU in data 03 apr 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 23 mar 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Nicholas Leigh come amministratore in data 15 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Ian Forrest come amministratore in data 31 gen 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Lawther il 31 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Timothy Nicholas Leigh il 31 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Charles Bennett Houlton il 31 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Ian Forrest il 31 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O 31/05/2010 Aldgate House 33 Aldgate High Street London EC3N 1AG United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jared Stephen Philip Cranney il 31 mag 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Staniforth come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRANNEY, Jared Stephen Philip | Segretario | c/o C/O Interior Services Group Plc 33 Aldgate High Street EC3N 1AG London Aldgate House United Kingdom | British | 74806700006 | ||||||
| HOULTON, Jonathan Charles Bennett | Amministratore | c/o Interior Services Group Plc 33 Aldgate High Street EC3N 1AG London Aldgate House United Kingdom | United Kingdom | British | 70905760002 | |||||
| LAWTHER, David | Amministratore | c/o Interior Services Group Plc 33 Aldgate High Street EC3N 1AG London Aldgate House United Kingdom | United Kingdom | British | 126540420001 | |||||
| HERRING, Brian William | Segretario | 10 The Circus BA1 2EW Bath Avon | British | 54999000001 | ||||||
| LEIGH, Timothy Nicholas | Segretario | 21 Beaconsfield Road Knowle BS4 2JE Bristol | British | 28351320001 | ||||||
| ADAMS, Alan John | Amministratore | Wesley Combe 19 Whitecroft Nailsworth GL6 0NS Stroud Gloucestershire | British | 28351290001 | ||||||
| BATES, David Leonard | Amministratore | Anjo 16 Bleadon Mill BS24 0BE Bleadon Avon | British | 10031440002 | ||||||
| BRADLEY, Robert | Amministratore | Foxfield Scot Lane, Chew Stoke BS40 8UW Bristol | British | 96305270001 | ||||||
| CLARK, Peter Arnold | Amministratore | 10 Down Road Winterbourne Down BS17 1BN Bristol Avon | British | 10377700001 | ||||||
| COLES, Roger Lindsey | Amministratore | Siston Court Cottage Magotsfield BS17 3LU Bristol Avon | British | 28351300001 | ||||||
| CRIPPS, Bernard John | Amministratore | 34 Chock Lane Westbury-On-Trym BS9 3EX Bristol | British | 1926290001 | ||||||
| DRYSDALE, Michael John | Amministratore | 12 Grove Road Coombe Dingle BS9 2RQ Bristol | Uk | British | 91324630001 | |||||
| FORREST, Colin Ian | Amministratore | Parklands Hambrook Lane Stoke Gifford BS34 8QU Bristol | United Kingdom | British | 56892240002 | |||||
| GILTSOFF, Mark | Amministratore | 10 Stoke Park Road Stoke Bishop BS9 1LF Bristol | British | 94679290001 | ||||||
| GREENHALGH, Peter Gerard | Amministratore | Garston Farm Garston BA11 1RU Frome Somerset | United Kingdom | British | 83636780001 | |||||
| HERRING, Brian William | Amministratore | 10 The Circus BA1 2EW Bath Avon | British | 54999000001 | ||||||
| JONES, Graham Roger David | Amministratore | Avondale London Road East Bathford BA1 7RB Bath Avon | British | 10377720002 | ||||||
| LEIGH, Timothy Nicholas | Amministratore | Parklands Hambrook Lane Stoke Gifford BS34 8QU Bristol | United Kingdom | British | 28351320001 | |||||
| NEILE, Ian David | Amministratore | 52 Dorset Way North Yate BS37 7SP Bristol | British | 58671410001 | ||||||
| RACKSTRAW, John William | Amministratore | Snowberry House Pelting Road Priddy BA5 3BA Wells Somerset | England | British | 16851180001 | |||||
| RITCHIE, James | Amministratore | 1 Farmcote Alderley Road GL12 7RP Hillesley Gloucestershire | British | 89095700001 | ||||||
| ROSS, Donald | Amministratore | Cherry Cottage The Follies Rectory Lane Cromhall GL12 8AN Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 10377750002 | ||||||
| STANIFORTH, Andrew John | Amministratore | Clos Coed Hir Whitchurch CF14 7BJ Cardiff 26 | United Kingdom | British | 142609680001 | |||||
| TROTTER, Steve | Amministratore | Kebbles Burford Road GL7 3ET Lechlade Gloucestershire | United Kingdom | British | 126539650001 | |||||
| WILLIAMS, John David | Amministratore | 9 Priory Avenue Westbury On Trym BS9 4DA Bristol | British | 77515470001 |
C.H. PEARCE CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 14/06/1999 | Creato il 26 mar 2003 Consegnato il 05 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts for the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the banks name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture | Creato il 31 gen 2003 Consegnato il 06 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 07 ago 1979 Consegnato il 08 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 152-162 kings road chelsea 8.24 jubilee place & joubert studios chelsea site of classic cinema kings road land at back of 58 markham street chelsea london title no: ngl 278092. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0