HANDLEMAN UK LIMITED

HANDLEMAN UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHANDLEMAN UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00931853
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HANDLEMAN UK LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova HANDLEMAN UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HANDLEMAN UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIFETIME ENTERTAINMENT LIMITED18 ott 199518 ott 1995
    PIC-A-TAPE LIMITED20 mag 198520 mag 1985
    CAR RADIO OF PRESTON LIMITED10 mag 196810 mag 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di HANDLEMAN UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 apr 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per HANDLEMAN UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 apr 2010

    5 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 apr 2009

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagineSH20

    Varie

    Memorandum of capital - processed 090109
    1 pagineMISC

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 28 apr 2007

    23 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di HANDLEMAN UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCORMICK, Martin
    The Barn Bryn Yr Eithin Llay Bank
    Cefn Y Bedd
    LL12 9YF Wrexham
    Segretario
    The Barn Bryn Yr Eithin Llay Bank
    Cefn Y Bedd
    LL12 9YF Wrexham
    British55987270002
    KOKKO, Rozanne
    49110 Hidden Woods Lane
    Shelby Township
    Michigan 48317
    Usa
    Amministratore
    49110 Hidden Woods Lane
    Shelby Township
    Michigan 48317
    Usa
    American132014830001
    MCCORMICK, Martin
    The Barn Bryn Yr Eithin Llay Bank
    Cefn Y Bedd
    LL12 9YF Wrexham
    Amministratore
    The Barn Bryn Yr Eithin Llay Bank
    Cefn Y Bedd
    LL12 9YF Wrexham
    British55987270002
    BAXTER, Anthony
    7 Cotterdale Close
    WA5 5ZA Warrington
    Cheshire
    Segretario
    7 Cotterdale Close
    WA5 5ZA Warrington
    Cheshire
    British46250090001
    SMITH, David
    Illtyd House 2 Ormande Close
    B63 2XY Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    Illtyd House 2 Ormande Close
    B63 2XY Halesowen
    West Midlands
    British3635870001
    ARABIS PLC
    Excalibur House Park Lane
    Handsworth
    B21 8LH Birmingham
    Segretario
    Excalibur House Park Lane
    Handsworth
    B21 8LH Birmingham
    42368660002
    ANGEL, Glyn Michael
    Woodlands
    Village Road
    CH3 7QN Waverton Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Woodlands
    Village Road
    CH3 7QN Waverton Chester
    Cheshire
    British72397310002
    BAXTER, Anthony
    7 Cotterdale Close
    WA5 5ZA Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    7 Cotterdale Close
    WA5 5ZA Warrington
    Cheshire
    British46250090001
    BRAUM, Thomas Jr
    54363 Pocahontas
    Shelby Township
    Michigan 48315
    Usa
    Amministratore
    54363 Pocahontas
    Shelby Township
    Michigan 48315
    Usa
    American94737480001
    CLINE, Peter
    1543 San Carlos Bay Drive
    Sanibel
    Florida 33957
    Usa
    Amministratore
    1543 San Carlos Bay Drive
    Sanibel
    Florida 33957
    Usa
    American67320050002
    CORPS, Richard Anthony
    29 Marshall Road
    Francombe
    GU7 3AT Godalming
    Surrey
    Amministratore
    29 Marshall Road
    Francombe
    GU7 3AT Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish94737520002
    DAVIS, Michael Ian
    Hurlstone House 8 Bentinck Road
    WA14 2BP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Hurlstone House 8 Bentinck Road
    WA14 2BP Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish14192220001
    FINLAY, Michael
    11 Freshwater Drive
    Weston
    CW2 59B Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    11 Freshwater Drive
    Weston
    CW2 59B Crewe
    Cheshire
    British96722140001
    FURBY, David Michael
    4 Hartley Road
    HG2 9DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Hartley Road
    HG2 9DQ Harrogate
    North Yorkshire
    British52378420001
    GREEN, Walter Ian
    Brome Park Farm
    Brome Avenue
    IP23 7HW Eye
    Suffolk
    Amministratore
    Brome Park Farm
    Brome Avenue
    IP23 7HW Eye
    Suffolk
    British34834740001
    GRIFFITHS, Geoffrey Mark
    4 Allandale
    Altrincham
    WA14 4PQ Cheshire
    Amministratore
    4 Allandale
    Altrincham
    WA14 4PQ Cheshire
    British67337290001
    GRIFFITHS, Michael Sean
    7 Ashbury Court
    Henley In Arden
    B95 5AF Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    7 Ashbury Court
    Henley In Arden
    B95 5AF Solihull
    West Midlands
    British66501810001
    GRIFFITHS, Richard Barry
    32 Claremont Road
    Birkdale
    PR8 4DY Southport
    Merseyside
    Amministratore
    32 Claremont Road
    Birkdale
    PR8 4DY Southport
    Merseyside
    British78714140001
    HARAM, Khaled
    2883 Baytree Court
    Rochester Hills
    Michigan 48306
    Usa
    Amministratore
    2883 Baytree Court
    Rochester Hills
    Michigan 48306
    Usa
    United States116689660001
    KIRBY, Robert Emmett
    411 South Old Woodward Ave Apt 506
    Birmingham
    Michigan
    48009
    Usa
    Amministratore
    411 South Old Woodward Ave Apt 506
    Birmingham
    Michigan
    48009
    Usa
    American116861450001
    LEACH, Andrew Keith
    4 Linwood Road
    B91 1HL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    4 Linwood Road
    B91 1HL Solihull
    West Midlands
    British25796070001
    MARKS, Maurice
    87 Kingsley Way
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0EZ London
    Amministratore
    87 Kingsley Way
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0EZ London
    EnglandBritish17070300002
    OUZMAN, Neil
    1 Longmeadow
    Wootton
    NN4 6AN Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Longmeadow
    Wootton
    NN4 6AN Northampton
    Northamptonshire
    British64669690001
    REVILL, Jeffrey, Mr.
    Meadow Park
    Irwell Vale Ramsbottom
    BL0 0QB Bury
    9
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Meadow Park
    Irwell Vale Ramsbottom
    BL0 0QB Bury
    9
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish49525730002
    ROLLINSON, David James
    Treetops 11 Park Crscent
    Cuddington
    CW8 2TY Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Treetops 11 Park Crscent
    Cuddington
    CW8 2TY Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish198485540001
    SALTER, Robert Antony Keith
    6 Oxford Drive
    Rogers
    Arkansas 72758
    Usa
    Amministratore
    6 Oxford Drive
    Rogers
    Arkansas 72758
    Usa
    British109815140001
    SCAPPATICCI, Roberto
    5 The White House
    Suffolk Road
    WA14 4QX Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    5 The White House
    Suffolk Road
    WA14 4QX Altrincham
    Cheshire
    Canadian67320580002
    SCHMID, Tom
    8507 Ranch Estates Road
    Clarkston
    Michigan 48348
    Usa
    Amministratore
    8507 Ranch Estates Road
    Clarkston
    Michigan 48348
    Usa
    American67320430001
    SEARLING, Richard
    Middle Lees 32 Knowsley Road
    Ainsworth
    BL2 5PY Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Middle Lees 32 Knowsley Road
    Ainsworth
    BL2 5PY Bolton
    Lancashire
    British56054240001
    STROME, Stephen
    4597 Kiftsgate Bend
    Bloomfield Hills
    Michigan 48302
    Usa
    Amministratore
    4597 Kiftsgate Bend
    Bloomfield Hills
    Michigan 48302
    Usa
    American74301600001
    TRYAN, Maria
    17555 Parkside
    Detroit
    FOREIGN Michigan 48221
    Usa
    Amministratore
    17555 Parkside
    Detroit
    FOREIGN Michigan 48221
    Usa
    American67320480001

    HANDLEMAN UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 15 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (including former agent the lenders or any of them on any account whatseover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Electric Capital Corporation as Administrative Agent, Agent and Lener (The Agent)
    Transazioni
    • 15 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 08 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the agents (including former agents), the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Silver Point Finance, Llc as Collateral Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 09 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all assets present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lasalle Bank Midwest National Association as Administrative Agent for the Banks
    Transazioni
    • 09 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 nov 1997
    Consegnato il 29 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 mar 1996
    Consegnato il 09 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms and provisions of the company's guarantee contained in a guaranteed secured loan note dated 4TH march 1996
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Excalibur Group PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 mar 1996
    Consegnato il 12 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 04 dic 1995
    Consegnato il 12 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums in ant account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 04 mag 1995
    Consegnato il 24 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums standing to the credit of any accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of omnibus guarantee and set-off
    Creato il 10 set 1993
    Consegnato il 24 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums to the credit of any accounts of the companies.........see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 set 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 set 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north west side of lund street preston t/no LA322085 with fixtures & fittings & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 lug 1991
    Consegnato il 17 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 lug 1991
    Consegnato il 17 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on north west side of lund street, preston. Title no. La 322085; and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 19 gen 1990
    Consegnato il 01 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 01 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 nov 1985
    Consegnato il 21 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Inc. All heritable property and assets in scotland (see doc M26). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1993Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 22 set 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 1976
    Consegnato il 21 set 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. With all fixtures fixed plant and machinery, fixed and floating charge see docs (M23 & 24) for more details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HANDLEMAN UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 nov 2010Data di scioglimento
    27 apr 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0