XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED
Panoramica
Nome della società | XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00932001 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AGENCYPORT SOFTWARE EUROPE LIMITED | 15 mag 2012 | 15 mag 2012 |
AGENCYPORT SOFTWARE EUROPE LTD. | 21 mar 2012 | 21 mar 2012 |
SWORD INSURANCE EUROPE LIMITED | 11 mar 2011 | 11 mar 2011 |
SWORD UK LIMITED | 20 gen 2009 | 20 gen 2009 |
INSURANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 13 mar 1998 | 13 mar 1998 |
COMPUTER ASSESSMENTS LIMITED | 14 mag 1968 | 14 mag 1968 |
Quali sono gli ultimi bilanci di XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven James Turpie come amministratore in data 15 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 feb 2022 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 22 feb 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 07 set 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 30 giu 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Steven James Turpie il 28 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Neal Halbard il 31 mar 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom a Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 22 mar 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 9 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 19 giu 2020
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 28 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Christopher Neal Halbard come amministratore in data 07 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Tina Anne Gough come amministratore in data 07 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Maruf Ahmad Majed come amministratore in data 26 feb 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Steven James Turpie come amministratore in data 04 mar 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 27 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALBARD, Christopher Neal | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | None Supplied | 152748570001 | ||||
WOODFINE, Michael Charles | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | Solictor | 208597210001 | ||||
BISSET, James Martin | Segretario | 25 West Court West Avenue LS8 2JP Leeds West Yorkshire | British | 15188580001 | ||||||
CUDDY, David | Segretario | 1 Blue Hill Grange LS12 4RG Leeds West Yorkshire | British | 40195900001 | ||||||
DAVIES, Heath John | Segretario | Castelnau Barnes SW13 9EX London 46 | British | Director | 105007360002 | |||||
HAUCK, Steven Arthur | Segretario | (8th Floor) Sleeper Street 02210 Boston 51 Ma Usa | 164444190001 | |||||||
LEIGHTON, Nigel Derrick | Segretario | 7 Fieldside Close CW4 8GD Goostrey Cheshire | British | 93251520001 | ||||||
NORGATE, Philip Neil | Segretario | International House 1 St. Katharines Way E1W 1UN London Sword Intech | British | 116191810001 | ||||||
STONE, Christopher Ronald | Segretario | 1 St Katharine's Way E1W 1UN London International House | 186961510001 | |||||||
BAKER, Christopher Francis Henry | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | Executive Director | 141579190001 | ||||
BINNS, Andrew Michael | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | None | 189560320001 | ||||
BISSET, James Martin | Amministratore | 25 West Court West Avenue LS8 2JP Leeds West Yorkshire | England | British | Director | 15188580001 | ||||
BRAU, Julia | Amministratore | 1 St Katharine's Way E1W 1UN London International House United Kingdom | Usa | American | Private Equity Investor | 181614370001 | ||||
BRIZIUS, Charles Albert | Amministratore | c/o Thomas H Lee Partners 100 Federal Street (35th Floor) Boston Charles A Brizius Ma 02110 Usa | United States | American | Private Equity Investor | 160037770001 | ||||
CARLISLE, James | Amministratore | 1 St Katharine's Way E1W 1UN London International House United Kingdom | Usa | American | Private Equity Investor | 181615010001 | ||||
CROOM, Timothy Llewellyn | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | None | 184906470001 | ||||
CUDDY, David | Amministratore | 1 Blue Hill Grange LS12 4RG Leeds West Yorkshire | British | Director | 40195900001 | |||||
DANTON, Raymond Philip | Amministratore | 6 Mallinson Oval HG2 9HH Harrogate North Yorkshire | British | Director | 50849720001 | |||||
DAVIES, Heath John | Amministratore | Castelnau Barnes SW13 9EX London 46 | United Kingdom | British | Director | 105007360002 | ||||
DEWS, Stephen Eric | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | None | 172816160001 | ||||
FILLOT, Francoise Marie | Amministratore | 286 Route De La Glande FRANCE Limonest 69760 France | France | French | Director | 76010150001 | ||||
GOUGH, Tina Anne | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | None Supplied | 229756300001 | ||||
GRAY, David William Hart | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | None Supplied | 224241390001 | ||||
HAUCK, Steven | Amministratore | 1 St Katharine's Way E1W 1UN London International House United Kingdom | Usa | American | Co-Ceo | 181614550001 | ||||
HOLLAND, Anthony Gerard | Amministratore | Ranworth Starrock Lane Chipstead CR5 3QD Coulsdon Surrey | England | British | Director | 44974520001 | ||||
JENKINS, Peter Charles | Amministratore | Southern Down All Saints Road SO41 3QL Lymington Hampshire | United Kingdom | British | Director | 68126830002 | ||||
LEIGHTON, Nigel Derrick | Amministratore | 7 Fieldside Close CW4 8GD Goostrey Cheshire | British | Director | 93251520001 | |||||
LORIA, Giovanni | Amministratore | Pancras Square N1C 4AG London One Pancras Square England | England | British | Company Executive | 134764880002 | ||||
LOVETT, Andy | Amministratore | 1 St Katharine's Way E1W 1UN London International House | United Kingdom | British | None | 189458090001 | ||||
MAJED, Maruf Ahmad | Amministratore | One Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Dxc United Kingdom | Singapore | American | None Supplied | 245085610001 | ||||
MATTHEWS, Anthony Hugh Johnston | Amministratore | Figs House West Parade RH12 2BZ Horsham Sussex | British | Director | 28266790001 | |||||
MILLS, Richard James | Amministratore | 18 Woodlands Grove Kippax LS25 7RW Leeds West Yorkshire | British | Director | 28266800001 | |||||
MOORE, Doreen Elizabeth | Amministratore | Craemore 598a Stone Gate Road LS17 6EL Leeds West Yorkshire | British | Director | 28266810001 | |||||
MOTTARD, Jacques Francois | Amministratore | 1 Rue Garnot 69450 St Cyr Au Mont D'Or 69450 France | France | French | Director | 99530940001 | ||||
NORGATE, Philip Neil | Amministratore | International House 1 St. Katharines Way E1W 1UN London Sword Intech | United Kingdom | British | Finance Director | 116191810003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xchanging Holdings Limited | 21 nov 2016 | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
09 nov 2016 | 20 nov 2016 | La società sa o ha ragione di credere che vi sia una persona registrabile in relazione alla società, ma non l'ha identificata. |
XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creato il 26 lug 1999 Consegnato il 04 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 23 mag 1995 Consegnato il 05 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land & buildings on the north side of manor street sheepscar leeds west yorkshire t/no WYK181048 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
XCHANGING SOFTWARE EUROPE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0