TH GROUP SERVICES LIMITED

TH GROUP SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTH GROUP SERVICES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00932159
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di TH GROUP SERVICES LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KVAERNER SERVICES LIMITED07 ott 200407 ott 2004
    AKER KVAERNER SERVICES UK LIMITED20 nov 200320 nov 2003
    KVAERNER SERVICES LIMITED19 lug 199619 lug 1996
    TRAFALGAR HOUSE SERVICES LIMITED25 giu 199125 giu 1991
    TRAFALGAR HOUSE GROUP SERVICES LIMITED01 apr 198401 apr 1984
    T.H.I.GROUP SERVICES LIMITED16 mag 196816 mag 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al02 apr 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma16 apr 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al02 apr 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2025

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2024

    18 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Old Bailey London EC4M 7AU a 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 26 lug 2024

    3 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2023

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2022

    14 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da , Tower Bridge House St. Katharines Way, London, E1W 1DD a 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 11 mag 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    16 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2021

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2020

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2019

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione delle attività

    9 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 01 ott 2018

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da , Betchworth House 57-65 Station Road, Redhill, Surrey, RH1 1DL, United Kingdom a 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 12 set 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    12 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da , Surrey House 36-44 High Street, Redhill, Surrey, RH1 1RH a 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 31 lug 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2016

    Stato del capitale al 13 apr 2016

    • Capitale: GBP 100,000,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 apr 2015

    Stato del capitale al 16 apr 2015

    • Capitale: GBP 100,000,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 apr 2014

    Stato del capitale al 11 apr 2014

    • Capitale: GBP 100,000,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAYCOCK, Rufus
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Segretario
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    British7584610001
    LAYCOCK, Rufus
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomBritish7584610002
    NILSEN, Runar
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Norwegian102391880002
    PEATE, Roland Duncan
    87 Bennetts Way
    Shirley
    CR0 8AG Croydon
    Surrey
    Segretario
    87 Bennetts Way
    Shirley
    CR0 8AG Croydon
    Surrey
    British7628800001
    ANSDELL, John Reginald Wardhaugh
    17 Randolph Avenue
    W9 1BH London
    Amministratore
    17 Randolph Avenue
    W9 1BH London
    British5094500001
    AXFORD, Ralph
    Cleveland 36 High Street
    Standon
    SG11 1LA Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cleveland 36 High Street
    Standon
    SG11 1LA Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish4938980001
    BRADY, David Alan
    Wayside 52 Sanderstead Court Avenue
    CR2 9AJ South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Wayside 52 Sanderstead Court Avenue
    CR2 9AJ South Croydon
    Surrey
    British26646140001
    BROWN, Richard
    22 Saint James Road
    Little Paxton
    PE19 6QW St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    22 Saint James Road
    Little Paxton
    PE19 6QW St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish105373250001
    BROWN, Richard
    22 Saint James Road
    Little Paxton
    PE19 6QW St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    22 Saint James Road
    Little Paxton
    PE19 6QW St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish105373250001
    CHARLTON, John Michael
    Dunstone
    5 Broomfield Ride
    KT22 0LR Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Dunstone
    5 Broomfield Ride
    KT22 0LR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritish73081460001
    COLES, Peter Wesley
    21 Lexham Gardens
    W8 5JJ London
    Amministratore
    21 Lexham Gardens
    W8 5JJ London
    British4841520001
    COOMBS, Thomas Brian
    22 Glebe Hyrst
    Sanderstead
    CR2 9JE South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    22 Glebe Hyrst
    Sanderstead
    CR2 9JE South Croydon
    Surrey
    British8207220001
    EASTON, Robert James Campbell, Dr
    Basement Flat 53c Cornwall Gardens
    SW7 4BG London
    Amministratore
    Basement Flat 53c Cornwall Gardens
    SW7 4BG London
    British73766180001
    ELLIS, Marilyn Rosemary Anne
    Villa Meera
    P O Box 60726
    8107 8107 Paphos
    Cyprus
    Amministratore
    Villa Meera
    P O Box 60726
    8107 8107 Paphos
    Cyprus
    CyprusBritish73974530001
    ELSDEN, John Kirk Saunderson
    Bucks Head
    Hammerpond Road
    RH13 6PF Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Bucks Head
    Hammerpond Road
    RH13 6PF Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish7584640001
    FARSTAD, Atle
    2 Burges Grove
    SW13 8BG London
    Amministratore
    2 Burges Grove
    SW13 8BG London
    Norwegian50057960002
    FENTON, Alan Lawson
    Estate House
    Gold Hill West
    SL9 9HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Estate House
    Gold Hill West
    SL9 9HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    UkBritish50227180001
    FOREID, Steffen
    Stensgaten 27
    FOREIGN Oslo
    0358
    Norway
    Amministratore
    Stensgaten 27
    FOREIGN Oslo
    0358
    Norway
    Norwegian102271580001
    FOSSE, Finn Erik
    5 Orchard Lane
    SW20 0SE London
    Amministratore
    5 Orchard Lane
    SW20 0SE London
    Norwegian118721520001
    FOWLER, Ian
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    Amministratore
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    British41294100001
    GAWLER, David
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    Amministratore
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    United KingdomSouth African167282630001
    GORMLY, Allan Graham
    56 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    56 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British1308140001
    HALFORD, William Timothy
    18 Conduit Mews
    W2 3RE London
    Amministratore
    18 Conduit Mews
    W2 3RE London
    British53468190001
    HEGGELUND, Jan Magne
    126 Silverdale Avenue
    KT12 1EH Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    126 Silverdale Avenue
    KT12 1EH Walton On Thames
    Surrey
    British67742180002
    IZZARD, Brian Alex
    Row Gardens Grove Close
    GU6 7LR Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Row Gardens Grove Close
    GU6 7LR Cranleigh
    Surrey
    British7159410001
    LALLEY, Michael John Ronald
    78 Sutherland Avenue
    Petts Wood
    BR5 1RB Orpington
    Kent
    Amministratore
    78 Sutherland Avenue
    Petts Wood
    BR5 1RB Orpington
    Kent
    British7159430001
    LYONS, Gerald
    14 Sheephouse Green
    Abinger Hammer
    RH5 6QW Dorking
    Surrey
    Amministratore
    14 Sheephouse Green
    Abinger Hammer
    RH5 6QW Dorking
    Surrey
    British7627850001
    MCLUSKIE, William Grindlay
    17 Pinfield Drive
    Barnt Green
    B45 8XA Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    17 Pinfield Drive
    Barnt Green
    B45 8XA Birmingham
    West Midlands
    British25437700001
    MUIR, Iain Alasdair Menzies
    The Warren 8 Pilgrims Place
    RH2 9LF Reigate
    Surrey
    Amministratore
    The Warren 8 Pilgrims Place
    RH2 9LF Reigate
    Surrey
    British17867300001
    PARKER, Eric Wilson, Sir
    Crimbourne House
    Crimbourne Lane Green Wisborough
    RH14 0HR Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Crimbourne House
    Crimbourne Lane Green Wisborough
    RH14 0HR Billingshurst
    West Sussex
    EnglandBritish36208980001
    RIDING, Allan
    16 Holmes Close
    Sunninghill
    SL5 9TJ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    16 Holmes Close
    Sunninghill
    SL5 9TJ Ascot
    Berkshire
    British26716850001
    ROSS, John
    32 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British40603910001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Amministratore
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    SHASHA, John David
    16 Queensmill Road
    SW6 6JS London
    Amministratore
    16 Queensmill Road
    SW6 6JS London
    British8207240001
    SIMPSON, Larry Norman
    37 Kings Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UX London
    Amministratore
    37 Kings Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UX London
    New Zealand54967490001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TH GROUP SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00001125
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TH GROUP SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A trust deed between the company kvaerner PLC (the "issuer") and the law debenture trust corporation P.L.C creating and or evidencing a charge or other security interest created by the company in favour of the trustee
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 27 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All principal, interest and other amounts owing in respect of the the external bonds and the external coupons and amounts due to the trustee in respect of fees, expenses and other liabilities
    Brevi particolari
    The subordinated bonds and subordinated coupons. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transazioni
    • 27 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security assignment of share purchase agreement
    Creato il 29 giu 2001
    Consegnato il 10 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dresdner kleinwrt wasserstein leasing june (1) limited, dresdner kleinwort wasserstein leasing september (2) limited, dresdner kleinwort wasserstein leasing december (5) limited (borrowers) to the chargee under or pursuant to the loan agreement and to the security documents
    Brevi particolari
    All the right,title,benefit and interest in and to the indemnities and the warranties to the extent that they are in respect of or relate to the leasing agreement including without limitations any sums payable pursuant to such indemnities and all claims rights and remedies arising out of or in connection with the acquisition agreement in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security assignment of share purchase agreement
    Creato il 31 lug 2000
    Consegnato il 10 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under or pursuant to the loan agreement and to the security documents
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest in and to the warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security assignment
    Creato il 21 dic 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee pursuant to the loan agreement of even date and to the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All the right title benefit and interest of the assignor in and to the representations and warranties set out out in paragraphs 14, 18, 19, 20, 21 and 22 of schedule 1 of the acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    TH GROUP SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil John Mather
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0